PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED

PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePENN HOUSE PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03287110
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Wo befindet sich PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3rd Floor 5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CIVILEMPLOY LIMITED03. Dez. 199603. Dez. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Feb. 2010

    Kapitalaufstellung am 10. Feb. 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 03. Dez. 2009

    1 SeitenCH02

    Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 03. Dez. 2009

    1 SeitenCH04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    14 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 10/11/2008
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten190

    Wer sind die Geschäftsführer von PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Sekretär
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3143222
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer6745658
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Sekretär
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    British74688330002
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British60687110001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    Hat PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 15. Sept. 2004
    Geliefert am 29. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental deed
    Erstellt am 30. Okt. 1997
    Geliefert am 11. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 30 october 1997
    Kurze Angaben
    The properties listed below together with all buildings, erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon and all improvements and additions thereto and all easements, rights and licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases, underleases, tenancies, agreements to lease, rights, covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. Land an buildings on the south west side of crown street manchester GM52341. L/h land and buildings on the west side of sidcup road and the north side of tilson road wythenshawe manchester LA328553.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 22. Aug. 1997
    Geliefert am 23. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising under or in connection with a sale and purchase agreement dated 23RD december 1996 and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a land and buildings on the south west side of crown street manchester and land on the south side of silvercroft street hulme t/nos: GM52341 and GM189836; l/h property k/a land and buildings on the west side of sidcup road and the north side of tilson road wythenshawe manchester t/no: LA328553 all fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property including any items at the original property; any proceeds of any insurance of the original real property; and a fixed charge over the rental income of the borrower. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Canada Life Assurance Company
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 1996
    Geliefert am 09. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and any holding or subsidiary company or any other group member to the chargee (as trustee for itself and the other lenders) on any account whatsoever or in any manner whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises on the west side of windsor bridge road bath north estate somerset AV81568 somerset hall somerset street bath AV33403 and AV33404 and AV184057 and all buildings and erections and by way of floating charge all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 23. Dez. 1996
    Geliefert am 04. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a sale and purchase agreement between the company the chargee and estates & general PLC dated 23RD december 1996 on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 13/15 old steine and 1A/1B st. James' street brighton t/n: ESX21909; l/h property k/a land and buildings on the south west side of crown street manchester and land on south side of silvercroft street hulme t/nos: GM52341 and GM189836 and other properties referred to in schedule together with all fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property, its goodwill and uncalled capital floating charge over the undertaking and property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Canada Life Assurance Company
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0