PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03287110 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?
- (7011) /
- (7020) /
Wo befindet sich PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3rd Floor 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CIVILEMPLOY LIMITED | 03. Dez. 1996 | 03. Dez. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Trafalgar Officers Limited am 03. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Reit(Corporate Services) Limited am 03. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED | Sekretär | 5 Wigmore Street W1U 1PB London |
| 79571870001 | ||||||||||
| BENADY, Maurice Moses | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 | Gibraltar | British | 69435160001 | |||||||||
| WHITE, Christopher George | Geschäftsführer | Line Wall Road Gibraltar 57/63 Gibraltar | Gibraltar | British | 80132540006 | |||||||||
| TRAFALGAR OFFICERS LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London 3rd Floor |
| 135316290001 | ||||||||||
| HOLLAND, Philip John | Sekretär | 9 Royle Close Chalfont St. Peter SL9 0BA Buckinghamshire | British | 74688330002 | ||||||||||
| WHITE, Christine | Sekretär | 31 Denmark Street WD17 4YA Watford Hertfordshire | British | 74900200002 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| CLEGG, Barry Stuart | Geschäftsführer | The Gate House 18a Ducks Hill Road HA6 2NR Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 11296610002 | |||||||||
| CULL, David Geoffrey Maurice | Geschäftsführer | 8 Centennial Court High Street WD3 1AW Rickmansworth Hertfordshire | British | 84076630001 | ||||||||||
| DOSSETT, Roger John | Geschäftsführer | Charlecote Harewood Road HP8 4UA Chalfont St Giles Buckinghamshire | England | British | 116927100001 | |||||||||
| HOLLAND, Philip John | Geschäftsführer | 61 Badgers Gate LU6 2BF Dunstable Bedfordshire | England | British | 163838050001 | |||||||||
| MALONE, Kenneth Daniel | Geschäftsführer | One Tree Cottage 18 Woodside Avenue HP9 1JJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 60687110001 | ||||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||||||
| REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED | Geschäftsführer | 5 Wigmore Street W1U 1PB London | 74030120002 |
Hat PENN HOUSE PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 15. Sept. 2004 Geliefert am 29. Sept. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 30. Okt. 1997 Geliefert am 11. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 30 october 1997 | |
Kurze Angaben The properties listed below together with all buildings, erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon and all improvements and additions thereto and all easements, rights and licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases, underleases, tenancies, agreements to lease, rights, covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance. Land an buildings on the south west side of crown street manchester GM52341. L/h land and buildings on the west side of sidcup road and the north side of tilson road wythenshawe manchester LA328553. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge | Erstellt am 22. Aug. 1997 Geliefert am 23. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee arising under or in connection with a sale and purchase agreement dated 23RD december 1996 and on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a land and buildings on the south west side of crown street manchester and land on the south side of silvercroft street hulme t/nos: GM52341 and GM189836; l/h property k/a land and buildings on the west side of sidcup road and the north side of tilson road wythenshawe manchester t/no: LA328553 all fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property including any items at the original property; any proceeds of any insurance of the original real property; and a fixed charge over the rental income of the borrower. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 23. Dez. 1996 Geliefert am 09. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and any holding or subsidiary company or any other group member to the chargee (as trustee for itself and the other lenders) on any account whatsoever or in any manner whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and premises on the west side of windsor bridge road bath north estate somerset AV81568 somerset hall somerset street bath AV33403 and AV33404 and AV184057 and all buildings and erections and by way of floating charge all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 23. Dez. 1996 Geliefert am 04. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with a sale and purchase agreement between the company the chargee and estates & general PLC dated 23RD december 1996 on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 13/15 old steine and 1A/1B st. James' street brighton t/n: ESX21909; l/h property k/a land and buildings on the south west side of crown street manchester and land on south side of silvercroft street hulme t/nos: GM52341 and GM189836 and other properties referred to in schedule together with all fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property, its goodwill and uncalled capital floating charge over the undertaking and property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0