HC-ONE (NHP8) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | HC-ONE (NHP8) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03287983 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HC-ONE (NHP8) LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich HC-ONE (NHP8) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House Archer Street DL3 6AH Darlington County Durham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HC-ONE (NHP8) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
NHP SECURITIES NO. 2 LIMITED | 05. Dez. 1996 | 05. Dez. 1996 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HC-ONE (NHP8) LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 29. Sept. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 29. Juni 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für HC-ONE (NHP8) LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 28. Mai 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 11. Juni 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 28. Mai 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für HC-ONE (NHP8) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2023 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 032879830054, erstellt am 12. Okt. 2023 | 179 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 032879830055, erstellt am 12. Okt. 2023 | 41 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 032879830056, erstellt am 12. Okt. 2023 | 53 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2022 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Cessation of Libra Careco Investments 2 Limited as a person with significant control on 21. Dez. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Hc-One (Nhp1) Limited as a person with significant control on 21. Dez. 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Libra Careco Limited as a person with significant control on 21. Dez. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Libra Careco Investments 2 Limited as a person with significant control on 21. Dez. 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Nhp Limited as a person with significant control on 21. Dez. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Libra Careco Limited as a person with significant control on 21. Dez. 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 032879830048 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 032879830049 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 032879830050 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 032879830053, erstellt am 27. Apr. 2021 | 216 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 032879830051, erstellt am 27. Apr. 2021 | 57 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 032879830052, erstellt am 27. Apr. 2021 | 90 Seiten | MR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HC-ONE (NHP8) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham England | United Kingdom | British | Director | 147997950001 | ||||
TUGENDHAT, Jams Walter | Geschäftsführer | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham | England | British | Company Director | 274658550001 | ||||
FLETCHER, Rachel Elizabeth | Sekretär | Flat 1 Basement 269 Magdalen Road Earlsfield SW18 3NZ London | British | 106745220001 | ||||||
FRANCIS, Daniel Fernley | Sekretär | Bartley Lodge 11 Marlborough Road Chandlers Ford SO53 5DJ Eastleigh Hampshire | British | Chartered Accountant | 44830480001 | |||||
GRAHAM, Annabel Susan | Sekretär | 9 Manor Mount SE23 3PY London | British | Company Secretary | 108637650001 | |||||
KAUL, Sheila | Sekretär | 35 Princes Court HA9 7JJ Wembley Middlesex | British | 70194600001 | ||||||
KILMARTIN, Adrian Robert | Sekretär | Church Farm Acton Turville GL9 1HD Badminton South Gloucestershire | British | Accountant | 11660010001 | |||||
MIDMER, Richard Neil | Sekretär | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | British | Company Director | 110640170001 | |||||
MIDMER, Richard Neil | Sekretär | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | British | Company Director | 110640170001 | |||||
MORTIMER, Rachel | Sekretär | 14 Huron Road SW17 8RB London | British | 102674500002 | ||||||
PANG, Lily | Sekretär | Calbourne Road SW12 8LW London 9 United Kingdom | Malaysian | Group Financial Controller | 140239060001 | |||||
POOLEY, Maureen | Sekretär | 12 Lodge Lane Old Catton NR6 7HG Norwich Norfolk | English | Corporate Controller | 51896650001 | |||||
AUBERY, Paul Richard | Geschäftsführer | 1 Malthouse Drive Regency Quay Chiswick W4 2NR London | British | Banker | 78253140001 | |||||
BARATTA, Joseph Patrick | Geschäftsführer | Park Avenue New York 345 Ny 10154 United States | Usa | American | Director | 94259330002 | ||||
BENSON, David Frederick | Geschäftsführer | 24 Middleton Road 01921 Boxford Massachusetts Usa | Usa | Company Director | 49415160001 | |||||
BERGBAUM, Arthur | Geschäftsführer | 23 Pine Grove Totteridge N20 8LB London | British | Company Director | 1770100001 | |||||
BLITZER, David Scott | Geschäftsführer | 5 Priory Walk SW10 9SP London | England | American | Director | 82685720001 | ||||
CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Geschäftsführer | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | Chartered Accountant | 98778780002 | |||||
COLVIN, William | Geschäftsführer | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Director | 51697890001 | ||||
COLVIN, William | Geschäftsführer | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 51697890001 | ||||
COLVIN, William | Geschäftsführer | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 51697890001 | ||||
DAVIES, William Jeremy | Geschäftsführer | The Manor House Great Somerford SN15 5EH Chippenham Wiltshire | England | British | Chartered Surveyor | 21505070001 | ||||
EIGHTEEN, Stephen Brian | Geschäftsführer | Flat 56 Cinnabar Wharf Central 24 Wapping High Street E1W 1NQ London | United Kingdom | British | Banker | 76313640003 | ||||
ELLERT, Richard John | Geschäftsführer | Cami Del Padro 10 Sant Vicenc De Montalt Barcelona Catalonia 08394 Spain | British | Company Director | 95944260001 | |||||
FARNELL, Adrian Colin | Geschäftsführer | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | Chartered Accountant | 43015720002 | ||||
FRANCIS, Daniel Fernley | Geschäftsführer | Bartley Lodge 11 Marlborough Road Chandlers Ford SO53 5DJ Eastleigh Hampshire | England | British | Chartered Accountant | 44830480001 | ||||
GRANT, Michael John | Geschäftsführer | Edwill Way BR3 6RY Beckenham 73 Kent | England | British | Company Director | 141668610001 | ||||
HARGRAVE, David Grant | Geschäftsführer | Trench Hill Painswick GL6 6TZ Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | Company Director | 23603220002 | ||||
HUTCHENS, James Justin | Geschäftsführer | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham | United Kingdom | American | Director | 238334580002 | ||||
JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Geschäftsführer | 25 Chiswick Quay W4 3UR London | England | British | Consultant | 108268030003 | ||||
MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | England | British | Company Director | 110640170001 | ||||
MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | The Garden House 30a Clare Lawn Avenue SW14 8BG London | England | British | Finance Director | 110640170001 | ||||
MOY, Neal St John | Geschäftsführer | 1 Highberry ME19 5QT Leybourne Kent | British | Bank Employee | 98781970001 | |||||
MURPHY, John | Geschäftsführer | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | Director | 26177180002 | |||||
NICHOLSON, Daniel Christopher | Geschäftsführer | 181 Seagrave Road SW6 1ST London | England | British | Chartered Surveyor | 77890230001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HC-ONE (NHP8) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libra Careco Limited | 21. Dez. 2021 | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Libra Careco Investments 2 Limited | 21. Dez. 2021 | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hc-One (Nhp1) Limited | 21. Dez. 2021 | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House County Durham England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Nhp Limited | 01. Mai 2017 | Archer Street DL3 6AH Darlington Southgate House Durham England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat HC-ONE (NHP8) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 12. Okt. 2023 Geliefert am 16. Okt. 2023 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 12. Okt. 2023 Geliefert am 16. Okt. 2023 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 12. Okt. 2023 Geliefert am 16. Okt. 2023 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 27. Apr. 2021 Geliefert am 29. Apr. 2021 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 27. Apr. 2021 Geliefert am 27. Apr. 2021 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 27. Apr. 2021 Geliefert am 27. Apr. 2021 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 30. Juni 2017 Geliefert am 10. Juli 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 30. Juni 2017 Geliefert am 06. Juli 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 30. Juni 2017 Geliefert am 05. Juli 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 25. Nov. 2014 Geliefert am 05. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Subjects known as lunan court albert street arbroath. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 25. Nov. 2014 Geliefert am 05. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Subjects known as hillside view netherlands road paisley title number REN69970. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 25. Nov. 2014 Geliefert am 05. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Subjects known as kinnaird court brown street falkirk title number STG13294. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 25. Nov. 2014 Geliefert am 03. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All and whole the subjects k/a balfarg kilmichael road glenrothes scotland t/no FFE6601. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 25. Nov. 2014 Geliefert am 03. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All and whole the subjects k/a hamewith lodge marchburn drive aberdeen scotland t/no ABN977. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 12. Nov. 2014 Geliefert am 22. Nov. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Lisnisky care home 16 lisnisky lane county armagh folio AR5691 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 12. Nov. 2014 Geliefert am 21. Nov. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Southmead grange & lodge portcawl rd south cornelly bridgend please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 23 february 2007 and | Erstellt am 15. Jan. 2007 Geliefert am 07. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects k/a balfarg glenrothes t/no FFE6601, all and whole the subjects k/a hamewith lodge marchburn drive aberdeen t/no ABN977, all and whole the subjects k/a hillside view nethercraigs road paisley t/no REN69970 (for further details of properties charged please see form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of mortgage/charge | Erstellt am 15. Jan. 2007 Geliefert am 01. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h unregistered property (if any) including without limitation all that property more particularly set out in part ii of schedule 1 to the deed of mortgage and all property registered at land registry of northern ireland including all that property more particularly set out in part iii of schedule 1 to the deed of mortgage. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
The standard security | Erstellt am 15. Jan. 2007 Geliefert am 01. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Subjects k/a balfarg glenrothes t/no FFE6601, subjects k/a hamewith lodge marchburn drive, aberdeen t/no ABN977, subjects k/a hillside view nethercraigs road paisley t/no REN69970 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A security deed | Erstellt am 15. Jan. 2007 Geliefert am 30. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at mill brow widnes t/no CH390856, f/h property k/a oaklands residential home forest glade basildon t/no EX550551, f/h land on the east side of croft lane cherry willingham t/no LL88541 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of mortgage/charge | Erstellt am 12. Dez. 2006 Geliefert am 21. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Saitfield lodge nursing home, 4 old saithfield road, belfast t/ns 244L and DN33050 copunty down laginsky private nursing home, 16 lisnisky lane, portadown, craigavon, county armagh t/n AR5691 rockfield nursing home, windmill road, newry, county down t/n DN134566 (for further details of property charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 12. Dez. 2006 Geliefert am 21. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h land k/a 116 clipstone road west, forest town, mansfield, nottinghamshire t/n NT237792 k/a avalon nursing home the f/h land k/a mill brow, widnes, cheshire t/n CH390856 k/a mill brow nursing home the f/h land k/a oaklands residential home, forest glade, dunton hills, basildon t/n EX550551 k/a oaklands residential home (for further details of property charged please refer to form 395) fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of mortgage/charge | Erstellt am 17. Okt. 2005 Geliefert am 20. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Saintfield lodge nursing home 4 old saintfield road belfast folio number 244L and DN33050 county down, lisnisky private nursing home 16 lisnisky lane portadown craigavon county armagh folio number AR5691 county armagh, rockfield nursing home windmill road newry county down folio number DN134566 county down. For details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Okt. 2005 Geliefert am 20. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. Avalon nursing home 116 clipstone road west forest town mansfield nottinghamshire t/no NT237792, mill brow nursing home mill brow widnes cheshire t/no CH390856, oaklands residential home forest glade dunton hills laindow essex t/no EX550551. For details of further properties charged please refr to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on the 2ND november 2005 and | Erstellt am 14. Okt. 2005 Geliefert am 10. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All and whole the subjects k/a balfarg glenrothes t/n FFE6601 all and whole the subjects k/a hamewth lodge marchburn drive aberdeen t/n ABN977 all and whole the subjects k/a hillside view netherlands road paisley t/n REN69970 * please refer to form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0