WOODHILL SECURITIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWOODHILL SECURITIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03294237
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WOODHILL SECURITIES LIMITED?

    • Verwaltung von Immobilien auf Provisions- oder Vertragsbasis (68320) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich WOODHILL SECURITIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Westminster Business Centre 10 Great Northy Way
    Nether Poppleton
    YO26 6RB York
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WOODHILL SECURITIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für WOODHILL SECURITIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom High Austby House Nesfield Ilkley West Yorkshire LS29 0BJ zum Westminster Business Centre 10 Great Northy Way Nether Poppleton York YO26 6RB am 01. März 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Jan. 2019

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    13 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 032942370012 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 032942370011 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 032942370010 vollständig

    4 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    12 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juli 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Cessation of Jill Elizabeth Tate as a person with significant control on 10. Juni 2017

    1 SeitenPSC07

    Änderung der Details des Direktors für Hilary Robinson am 29. Juni 2017

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Hilary Robinson am 29. Juni 2017

    1 SeitenCH03

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    5 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 032942370012, erstellt am 29. Juni 2016

    41 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    2 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von WOODHILL SECURITIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROBINSON, Hilary
    The Old Green
    DT9 3JY Sherborne
    1
    Dorset
    England
    Sekretär
    The Old Green
    DT9 3JY Sherborne
    1
    Dorset
    England
    British98479560001
    ROBINSON, Hilary
    The Old Green
    DT9 3JY Sherborne
    1
    England
    Geschäftsführer
    The Old Green
    DT9 3JY Sherborne
    1
    England
    United KingdomBritish98479560006
    TATE, Jill Elizabeth
    High Austby House
    Nesfield
    LS29 0BJ Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    High Austby House
    Nesfield
    LS29 0BJ Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish50890240002
    TATE, John Stuart
    High Austby House
    Nesfield
    LS29 0BJ Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    High Austby House
    Nesfield
    LS29 0BJ Ilkley
    West Yorkshire
    United KingdomBritish50890340002
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WOODHILL SECURITIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mrs Jill Elizabeth Tate
    Nesfield
    LS29 0BJ Ilkley
    High Austby House
    West Yorkshire
    06. Apr. 2016
    Nesfield
    LS29 0BJ Ilkley
    High Austby House
    West Yorkshire
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Mrs Hilary Robinson
    10 Great Northy Way
    Nether Poppleton
    YO26 6RB York
    Westminster Business Centre
    06. Apr. 2016
    10 Great Northy Way
    Nether Poppleton
    YO26 6RB York
    Westminster Business Centre
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: New Zealand
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat WOODHILL SECURITIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 29. Juni 2016
    Geliefert am 08. Juli 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    F/H 71/75 new roadside horsforth leeds t/n WYK103922. F/h 110/112 marton drive blackpool t/n LA313306/LA464023/LA859820/LA860845/LA860850/LA896646. For more details please refer to the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 14. Mai 2016
    Geliefert am 17. Mai 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    None.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 12. Sept. 2013
    Geliefert am 13. Sept. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    F/H property at 32 wellington street, barnsley, south yorkshire t/no SYK364861. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal and general charge
    Erstellt am 27. Aug. 2010
    Geliefert am 10. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any group member on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property at unit 6 ignite magna way rotherham south yorkshire by way of fixed charge other property at any time hereinafter vested in the company all the company's uncalled capital for the time being and all its intellectual property rights and all other f/h and l/h property the company's stock in trade and plant all it's land interests it's book debts by way of assignment the related rights the company's undertaking by way of floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 20. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 27. Aug. 2010
    Geliefert am 10. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any group member on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to any income arising in respect of any rental or other money payable under any lease together with all rent related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Santander UK PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 20. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge deed
    Erstellt am 26. Juni 2002
    Geliefert am 29. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a airedale house (formerly k/a ashley mills), ashley lane, shipley t/no. WYK81582 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property. Fixed charge all fixtures fittings plant and machinery theron. Floating charge the undertaking and all other property assets and rights of the company.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 29. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge deed
    Erstellt am 18. Apr. 2002
    Geliefert am 20. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 40 roseville road leeds land and buildings on the north west side of roseville road leeds t/no: WYK489510 floating charge the. Undertaking and all property and assets. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge deed
    Erstellt am 20. Dez. 2001
    Geliefert am 28. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 110/112 marton drive and 32/34 harcourt rd,blackpool; t/nos LA464023,LA860845,LA859820,LA860850 and LA896649; and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge deed
    Erstellt am 20. Aug. 2001
    Geliefert am 29. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 64-68 (even) greenfield road st helens t/no;-LA271670. Assigns the goodwill of the business the benefit of the licences and by way of floating charge the undertaking and all other property and assets both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge deed
    Erstellt am 27. Aug. 1999
    Geliefert am 02. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever the charge deed is made for securing further advances (if any)
    Kurze Angaben
    31 high street,alfreton together with all buildings thereon and all fixtures.specific charge all the income from time to time arising or payable to or on behalf of the company in relation to the property and the proceeds of sale.assigns the related rights.fixed charge the equipment and goods listed in the charge deed (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 16. Feb. 1998
    Geliefert am 26. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings being 12 market street shaw oldham t/no;-GM387933 together with goodwill and benefit of all licences and floating charge the undertaking all other property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 20. Feb. 1997
    Geliefert am 05. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that freehold land and buildings known as grandways block new roadside, horsforth, leeds, west yorkshire title number WYK103922 including all additions and alterations thereto all rights and interest in the same and all buildings fixtures and fixed plant and equipment, an assignment on the goodwill of the business and the benefit of any licences. Floating charge over the undertaking and all other property and assets both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock Building Society
    Transaktionen
    • 05. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat WOODHILL SECURITIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Jan. 2019Beginn der Liquidation
    12. Nov. 2019Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John William Butler
    Westminster Business Centre 10 Great North Way
    YO26 6RB Nether Poppleton
    York
    Praktiker
    Westminster Business Centre 10 Great North Way
    YO26 6RB Nether Poppleton
    York
    Andrew James Nichols
    Westminster Business Centre 10 Great North Way
    YO26 6RB Nether Poppleton
    York
    Praktiker
    Westminster Business Centre 10 Great North Way
    YO26 6RB Nether Poppleton
    York

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0