PCV HP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePCV HP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03296331
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PCV HP LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PCV HP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KPMG LLP
    15 Canada Square Canary Wharf
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PCV HP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FREEHOLD PORTFOLIOS HP LIMITED24. Dez. 199624. Dez. 1996

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PCV HP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für PCV HP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2018

    6 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2017

    6 SeitenLIQ03

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2016

    4 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:court order - removal/ replacement of liquidator
    30 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2015

    4 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB zum 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL am 12. Apr. 2015

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ zum 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB am 16. Okt. 2014

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    7 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 23. Sept. 2014

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 25. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 17. Sept. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    9 SeitenAA

    Ernennung von Mr David Leonard Grose als Direktor

    3 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von PCV HP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Sekretär
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Australian57113450003
    GROSE, David Leonard
    Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House 18
    Geschäftsführer
    Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House 18
    United KingdomBritish120479020002
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish6815470021
    MOUSLEY, Emily Ann
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    Geschäftsführer
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    United KingdomBritish155262770001
    LINEOBTAIN LIMITED
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    Sekretär
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    87536870003
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritish100504300001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Geschäftsführer
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritish108586450001
    EVANS, Alasdair David
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    Geschäftsführer
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    United KingdomBritish130019430001
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    British33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    Geschäftsführer
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    British93017010002
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Geschäftsführer
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritish38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Geschäftsführer
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritish4779170003
    FP FINANCIAL LDC
    Caledonian House
    Mary Street
    Georgetown
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    Geschäftsführer
    Caledonian House
    Mary Street
    Georgetown
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    49335910001

    Hat PCV HP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental debenture
    Erstellt am 28. März 2003
    Geliefert am 15. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All shares held by the company and/or any nominee on it's behalf and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft London Branch,(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2001
    Geliefert am 02. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 73 and 75 high street,rhyl title absolute under t/n WA493457 for further details of all property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee Tothe Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture between the company (formerly known as freehold portfolios hp limited) each chargor and the security trustee
    Erstellt am 09. Feb. 2000
    Geliefert am 21. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whather actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to a). Each senior finance party under each senior finance document; or b). Each mezzanine finance party under each mezzanine finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985.
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutchen Bank, London Branch(As Agent and Trustee for the Senior Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties)
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 22. Juni 1999
    Geliefert am 08. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from touchdown co.limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of touchdown co.limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assigned by way of charge all the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of: 53 high street newcastle under lyme,64 high street and black swan yard andover,53/55 high street goldaming,2/3 west street farnham,41 fore street trowbridge.for further details of property charged please refer to form 395.other than sums due to the company by way of insurance rent service charge or any vat payable to the company thereon including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security and any proceeds of the forgoing.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited
    Transaktionen
    • 08. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 22. Juni 1999
    Geliefert am 08. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from touchdown co.limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of touchdown co.limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union mortgage finance limited any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    53 high street newcastle under lyme-SF260136;53/55 high street godalming-SY287174;2/3 west street farnham-SY149465 and SY494929 for further details of property charged please refer to form 395.together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto, all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed, floating charge the whole of the property, assets, rights and revenues including the uncalled share capital (if any).
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (Life) Limited
    Transaktionen
    • 08. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 12. Jan. 1999
    Geliefert am 27. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    Kurze Angaben
    41 fore street trowbridge wiltshire WT145469,11 exchange walk nottingham NT304339,8 high street banbury t/n ON132306 and other properties with all buildings erection fixtures fittings underleases and agreement please refer to form 395 for details of further chrged properties and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (General) Limitedas Trustee for Itself and Any Other Lender or Any Lender
    Transaktionen
    • 27. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 31. Okt. 1997
    Geliefert am 19. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    Kurze Angaben
    F/H land being 48/50 south street romford egl 207769 with all buildings erections and fixtures (inc, trade fixtures) fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment and release
    Erstellt am 31. Okt. 1997
    Geliefert am 19. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 4TH february 1997
    Kurze Angaben
    The rents arising in respect of 48/50 south street romford egl 207769.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 17. Feb. 1997
    Geliefert am 26. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any lender (as defined) or for or in respect of which the company may be liable to the chargee or any lender on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The whole right title and interest in the assigned rights being all the rights titles benefits and interests of the company to the rents including the rights to receive the same and the full benefit of any guarantee or security for the performance thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage (General) Limitedas Trustee for Itself and the Other Lenders ("the Trustee")
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 04. Feb. 1997
    Geliefert am 20. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The properties being 76/76A high street, newmarket-SKJ154736 and the other properties described on the schedule attached to the form M395 with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fittings thereon, rights, licences, leases and a floating charge over all property, assets, rights and revenues including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 1998Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. März 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 04. Feb. 1997
    Geliefert am 20. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By clause 2 of the assignment all rights, titles, benefits and interests to all monies incurred to the company under occupational lease/s in respect of 76/76A high street, newmarket-SKJ154736 and the other properties described in the schedule attached to the form M395. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 1998Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 27. März 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 08. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 13TH february 1997
    Erstellt am 03. Feb. 1997
    Geliefert am 25. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole those shop premises with ancillary storage and office accomodation on basement ground and first floors in the burgh of falkirk and county of stirling now generally known as numbers one hundred and eighteen to one hundred and twenty high street falkirk t/n stg 10222.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (General) Limitedas Trustee for Itself and Others
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PCV HP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Feb. 2019Aufgelöst am
    23. Sept. 2014Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0