GNS PROPERTY SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GNS PROPERTY SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03296707 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Crown Way NN10 6BS Rushden England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Terry Morris als Geschäftsführer am 01. Dez. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Feb. 2017 bis 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Feb. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Dreier als Direktor am 10. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Dave Lissy als Direktor am 10. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Elizabeth Boland als Direktor am 10. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Kramer als Sekretär am 10. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr James Walter Tugendhat als Direktor am 10. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Company Secretary Asquith House 34 Germain Street Chesham Buckinghamshire HP5 1LH zum 2 Crown Way Rushden NN10 6BS am 14. Nov. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adam David Sage als Sekretär am 10. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Feb. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Company Secretary Asquith House 34 Germain Street Chesham Bucks HP5 1SJ England* am 11. Dez. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER, Stephen | Sekretär | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | 218500000001 | |||||||
| BOLAND, Elizabeth | Geschäftsführer | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United States | American | 70853820001 | |||||
| DREIER, Stephen | Geschäftsführer | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United States | American | 211308080001 | |||||
| LISSY, Dave | Geschäftsführer | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United States | American | 218331690001 | |||||
| TUGENDHAT, James Walter | Geschäftsführer | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | United Kingdom | British | 218306870001 | |||||
| ALLY, Bibi Rahima | Sekretär | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 38963210003 | ||||||
| AUGHTERSON, Peter William | Sekretär | Farley Hill House Church Lane RG7 1UP Farley Hill Berkshire | British Australian | 37698830004 | ||||||
| BROWNE, Lorna Barrington | Sekretär | 26 Hallmead Road SM1 1RP Sutton Surrey | British | 42236390001 | ||||||
| BUXTON-SMITH, Maria Rita | Sekretär | 1 Whitsun Pasture Willen Park MK15 9DQ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 39442340001 | ||||||
| FAIRHURST, Russell William | Sekretär | Flat 1 Elaine Court 123 Haverstock Hill NW3 4RT London | British | 44556020002 | ||||||
| HENDRIE, Neal Malcolm | Sekretär | 74 The Drive UB10 8AQ Uxbridge Middlesex | British | 40848270002 | ||||||
| SAGE, Adam David | Sekretär | c/o Company Secretary 34 Germain Street HP5 1LH Chesham Asquith House Buckinghamshire United Kingdom | 156315510001 | |||||||
| YARROW, Nicholas John | Sekretär | Chiltern View, 27 Cobbetts Ride HP23 4BZ Tring Hertfordshire | British | 127478700001 | ||||||
| AUGHTERSON, Peter William | Geschäftsführer | Farley Hill House Church Lane RG7 1UP Farley Hill Berkshire | British Australian | 37698830004 | ||||||
| CLARKE, James | Geschäftsführer | Jade Place Wendover Road HP17 0TU Butlers Cross Buckinghamshire | British | 84641000001 | ||||||
| COLLETT, Brian | Geschäftsführer | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | 32267100002 | ||||||
| FORD, Russell Mark | Geschäftsführer | Elm Field House Moreton OX9 2HS Thame South Oxfordshire | United Kingdom | British | 108597900005 | |||||
| HENDRIE, Neal Malcolm | Geschäftsführer | 74 The Drive UB10 8AQ Uxbridge Middlesex | England | British | 40848270002 | |||||
| MORRIS, Andrew Terry | Geschäftsführer | The Kiln Malthouse Close Ashbury SN6 8LN Swindon Wiltshire | England | British | 123609540001 | |||||
| PHILLIPS, Mark Randall | Geschäftsführer | Scotts Cottage Scots Lane MK18 2HX Adstock Buckinghamshire | United Kingdom | British | 80508130001 | |||||
| PHILPOTT, Stephen John Randall | Geschäftsführer | St John's Cottage Cherry Tree Lane SL3 6JE Fulmer Berkshire | United Kingdom | British | 45243130001 | |||||
| RHODES, Phillip Baverstock | Geschäftsführer | 12 Peterborough Villas SW6 2AT London | United Kingdom | British | 103078920001 | |||||
| RING, Ronald Arthur | Geschäftsführer | 7 Georgian Close Abbeydale GL4 5DG Gloucester Gloucestershire | United Kingdom | British | 52543770001 | |||||
| SAGE, Adam David | Geschäftsführer | Orbital House Park View Road HP4 3EY Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 216961780001 | |||||
| YARROW, Nicholas John | Geschäftsführer | Chiltern View, 27 Cobbetts Ride HP23 4BZ Tring Hertfordshire | England | British | 127478700001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GNS PROPERTY SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asquith Court Holdings Limited | 30. Nov. 2016 | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat GNS PROPERTY SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 11. Juni 2002 Geliefert am 21. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| By a security accession deed between the company, chestnutbay limited (the "parent") and dresdner bank ag, london branch (the "security agent") the company acceded to a debenture dated 10 may 2001, between inter alia, the parent and the security agent | Erstellt am 10. Mai 2001 Geliefert am 23. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies or liabilities due, owing or incurred to any secured party by any charging company or any other obligor at present or in the future, including all liabilities in connection with any notes, bills or other instruments accepted by any secured party for or at the request of an obligor and all losses incurred by any secured party in connection therewith (all terms as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Juni 1999 Geliefert am 17. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plot 4, south east of cloverfield hinkley leicestershire t/n LT228396, land on the south of milford road walton on the hill staffordshire t/n SF301213 and land lying to the north of lowry road west ardsley west yorkshire t/n WYK506006. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Juni 1999 Geliefert am 10. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0