BRAYFORD PARTNERSHIP LIMITED

BRAYFORD PARTNERSHIP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRAYFORD PARTNERSHIP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03297024
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRAYFORD PARTNERSHIP LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich BRAYFORD PARTNERSHIP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRAYFORD PARTNERSHIP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRAYFORD PARTNERSHIP LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRAYFORD PARTNERSHIP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 23. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Dez. 2013

    Kapitalaufstellung am 24. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Ernennung von Mr Nicholas John Child als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Michael Bales als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    10 SeitenAA

    Ernennung von Mr Michael Howard Bales als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Culliford als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Marcus James Miles Jolly am 13. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Marcus James Miles Jolly am 13. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Frederick Martin am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Robert Malcolm Culliford am 19. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Michael Howard Bales am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Wer sind die Geschäftsführer von BRAYFORD PARTNERSHIP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BALES, Michael Howard
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Sekretär
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    British2645510001
    CHILD, Nicholas John
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Geschäftsführer
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    EnglandBritish146660790001
    JOLLY, Marcus James Miles
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Geschäftsführer
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    United KingdomBritish68901830008
    JOLLY, Robert Miles
    Essex House
    Burton By Lincoln
    LN1 2RD Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Essex House
    Burton By Lincoln
    LN1 2RD Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritish2200140001
    MARTIN, Stephen Frederick
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Geschäftsführer
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    EnglandBritish117868520002
    COLLINGWOOD, Martin Bernard
    17 Desmond Avenue
    HU6 7JY Hull
    North Humberside
    Sekretär
    17 Desmond Avenue
    HU6 7JY Hull
    North Humberside
    British70996440003
    PEET, Norman
    13 Scotter Road
    Laughton
    DN21 3PT Gainsborough
    Lincolnshire
    Sekretär
    13 Scotter Road
    Laughton
    DN21 3PT Gainsborough
    Lincolnshire
    British14883920001
    WILSON, Alan
    20 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    Sekretär
    20 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    British147755040001
    FNCS SECRETARIES LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011830001
    BALES, Michael Howard
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Geschäftsführer
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    United KingdomBritish2645510001
    BUTCHER, Roy
    St Andrew's House
    Castle Howard Road
    YO17 7AY Malton
    N Yorkshire
    Geschäftsführer
    St Andrew's House
    Castle Howard Road
    YO17 7AY Malton
    N Yorkshire
    EnglandBritish364670031
    CULLIFORD, Robert Malcolm
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Geschäftsführer
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    EnglandBritish178618170001
    DIXON, George William
    Carpenters Cottage
    Brattleby
    LN1 2SQ Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Carpenters Cottage
    Brattleby
    LN1 2SQ Lincoln
    Lincolnshire
    British14883930006
    FRANCE, Nigel John
    Beechcroft
    Burton
    LN1 2RD Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Beechcroft
    Burton
    LN1 2RD Lincoln
    Lincolnshire
    British4254450001
    IVES, Simon George
    Highfield
    Thornton Road, South Kelsey
    LN7 6PS Market Rasen
    Geschäftsführer
    Highfield
    Thornton Road, South Kelsey
    LN7 6PS Market Rasen
    EnglandBritish18924830003
    FNCS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011820001

    Hat BRAYFORD PARTNERSHIP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Aug. 2004
    Geliefert am 19. Aug. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land situate at green lane lincoln. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Feb. 2003
    Geliefert am 12. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land situated fronting the ropewalk green lane area lincoln. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Transfer of land
    Erstellt am 28. Feb. 2003
    Geliefert am 05. März 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The sum of £125,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land at the ropewalk lincoln.
    Berechtigte Personen
    • Brb (Residuary) Limited
    Transaktionen
    • 05. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Feb. 2001
    Geliefert am 28. Feb. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the north east side of beevor street lincoln t/no: LL37042. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Feb. 1998
    Geliefert am 03. März 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being 3.67 acres of land adjacent to the roundabout at south brayford lincoln.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Feb. 1998
    Geliefert am 03. März 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property being 6.16 acres of land at south brayford,lincoln.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Feb. 1998
    Geliefert am 26. Feb. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0