CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD

CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03302431
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    • Vorschule (85100) / Erziehung

    Wo befindet sich CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2 Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HATTON HILL DAY NURSERY LIMITED 04. März 199704. März 1997
    128 QUARRY STREET LIMITED14. Jan. 199714. Jan. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Dez. 2015

    Kapitalaufstellung am 17. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 18. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 100
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account be cancelled 03/11/2015
    RES13

    Beendigung der Bestellung von Mary Ann Tocio als Geschäftsführer am 01. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 22. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 104
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Feb. 2014

    Kapitalaufstellung am 06. Feb. 2014

    • Kapital: GBP 104
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Stephen Kramer als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Stephen Dreier als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    12 SeitenAA

    Ernennung von Stephen Dreier als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Elizabeth Boland als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von David Lissy als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mary Ann Tocio als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Ussy als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mary Tocio als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Boland als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Sekretär
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    171973630001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican170443250001
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican218331690001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Sekretär
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    HAYNES, David Charles
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    Sekretär
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    British27595320001
    HERRINGTON, Denise Elaine
    8 Springfield Crescent
    RH12 2PP Horsham
    West Sussex
    Sekretär
    8 Springfield Crescent
    RH12 2PP Horsham
    West Sussex
    British39340000001
    HURRAN, Anthony Robert
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    Sekretär
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    British104970440001
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Sekretär
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    British169843310001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Sekretär
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British134350220001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Geschäftsführer
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican70853820001
    BROSNAN, Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomIrish102089360002
    BULL, Malcolm Richard
    Verlands Pond Road
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Verlands Pond Road
    GU22 0JY Woking
    Surrey
    EnglandBritish10155680001
    CARNEY, Joseph Gerard
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    Geschäftsführer
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    United KingdomIrish89273480001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Geschäftsführer
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican170443250001
    GOODYEAR, Christine
    Grafton House
    Bentley
    GU10 5HY Farnham
    7 Hatchford Manor
    Surrey
    Geschäftsführer
    Grafton House
    Bentley
    GU10 5HY Farnham
    7 Hatchford Manor
    Surrey
    EnglandBritish38722410001
    HAYNES, David Charles
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    9 Nether Beacon
    WS13 7AT Lichfield
    Staffordshire
    British27595320001
    HERRINGTON, Denise Elaine
    8 Springfield Crescent
    RH12 2PP Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    8 Springfield Crescent
    RH12 2PP Horsham
    West Sussex
    British39340000001
    HURRAN, Anthony Robert
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandBritish184743670001
    LEWIS, David
    78 Macdonald Road
    GU18 5XY Lightwater
    Surrey
    Geschäftsführer
    78 Macdonald Road
    GU18 5XY Lightwater
    Surrey
    British51773710002
    MALCOLMSON, John Bryce
    2 Mahonia Close
    West End
    GU24 9NX Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Mahonia Close
    West End
    GU24 9NX Woking
    Surrey
    British51773690002
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish115340530001
    TICE, Richard James Sunley
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Old Rectory
    Church Lane Lathbury
    MK16 8JY Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish151240670006
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Geschäftsführer
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    UsaUsa177507090001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    UsaUsa177507090001
    USSY, David
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Geschäftsführer
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    UsaUsa169819280001
    WHITLAM, Paul
    Millmoor 18 Drayhorse Drive
    GU19 5RF Bagshot
    Surrey
    Geschäftsführer
    Millmoor 18 Drayhorse Drive
    GU19 5RF Bagshot
    Surrey
    British47737380001

    Hat CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Accession deed to intercreditor deed
    Erstellt am 06. Juni 2005
    Geliefert am 16. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company agrees to become a party to and be bound by the intercreditor deed as an obligor, will upon demand by the security trustee pay an amount equal to the amount of all payments or distributions of or in respect of any junior liablities in cash or in kind;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transaktionen
    • 16. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security accession deed
    Erstellt am 06. Juni 2005
    Geliefert am 16. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1) l/h property k/a the old toll house and the new toll house, sandown park, esher, surrey, 2) l/h property k/a the green, frimley green, surrey GU16 6HF, 3) l/h property k/a rushmoor independent school, 40 reading road, farnborough, see form 395 for other properties charged; and any interest in any other land, all shares and all related distribution rights;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transaktionen
    • 16. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Jan. 2003
    Geliefert am 08. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a hatton hill day nursery 40 reading road farnborough hampshire GU14 6NB. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Jan. 2003
    Geliefert am 08. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a hatton hill day nursery 1 the green frimley green camberley surrey GU16 6HF. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2002
    Geliefert am 17. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that leasehold property known as hatton hill day nursery hatton hill windlesham surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2002
    Geliefert am 17. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that leashold property known as land and premises situate at and known at the old toll house and the new toll house sandown park surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Nov. 2002
    Geliefert am 17. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0