CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD
Überblick
| Unternehmensname | CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03302431 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?
- Vorschule (85100) / Erziehung
Wo befindet sich CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Crown Court NN10 6BS Rushden Northamptonshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HATTON HILL DAY NURSERY LIMITED | 04. März 1997 | 04. März 1997 |
| 128 QUARRY STREET LIMITED | 14. Jan. 1997 | 14. Jan. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Nov. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mary Ann Tocio als Geschäftsführer am 01. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Kramer als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Dreier als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Stephen Dreier als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Elizabeth Boland als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von David Lissy als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mary Ann Tocio als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Ussy als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mary Tocio als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Boland als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER, Stephen | Sekretär | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | 171973630001 | |||||||
| BOLAND, Elizabeth | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 70853820001 | |||||
| DREIER, Stephen | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 170443250001 | |||||
| LISSY, Dave | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 218331690001 | |||||
| HATHER, Jon | Sekretär | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | 68848420004 | ||||||
| HAYNES, David Charles | Sekretär | 9 Nether Beacon WS13 7AT Lichfield Staffordshire | British | 27595320001 | ||||||
| HERRINGTON, Denise Elaine | Sekretär | 8 Springfield Crescent RH12 2PP Horsham West Sussex | British | 39340000001 | ||||||
| HURRAN, Anthony Robert | Sekretär | 10 St Marks Road Ealing W5 3JS London | British | 104970440001 | ||||||
| KRAMER, Stephen | Sekretär | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | British | 169843310001 | ||||||
| MOORE, Matthew Jon | Sekretär | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | 134350220001 | ||||||
| BOLAND, Elizabeth | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | United States | American | 70853820001 | |||||
| BROSNAN, Paul | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 102089360002 | |||||
| BULL, Malcolm Richard | Geschäftsführer | Verlands Pond Road GU22 0JY Woking Surrey | England | British | 10155680001 | |||||
| CARNEY, Joseph Gerard | Geschäftsführer | 272 Gunnersbury Avenue W4 5QB London Suite 2 Chiswick Place | United Kingdom | Irish | 89273480001 | |||||
| DREIER, Stephen | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | United States | American | 170443250001 | |||||
| GOODYEAR, Christine | Geschäftsführer | Grafton House Bentley GU10 5HY Farnham 7 Hatchford Manor Surrey | England | British | 38722410001 | |||||
| HAYNES, David Charles | Geschäftsführer | 9 Nether Beacon WS13 7AT Lichfield Staffordshire | British | 27595320001 | ||||||
| HERRINGTON, Denise Elaine | Geschäftsführer | 8 Springfield Crescent RH12 2PP Horsham West Sussex | British | 39340000001 | ||||||
| HURRAN, Anthony Robert | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | England | British | 184743670001 | |||||
| LEWIS, David | Geschäftsführer | 78 Macdonald Road GU18 5XY Lightwater Surrey | British | 51773710002 | ||||||
| MALCOLMSON, John Bryce | Geschäftsführer | 2 Mahonia Close West End GU24 9NX Woking Surrey | British | 51773690002 | ||||||
| MOORE, Matthew Jon | Geschäftsführer | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 115340530001 | |||||
| TICE, Richard James Sunley | Geschäftsführer | Old Rectory Church Lane Lathbury MK16 8JY Newport Pagnell Buckinghamshire | United Kingdom | British | 151240670006 | |||||
| TOCIO, Mary Ann | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | Usa | Usa | 177507090001 | |||||
| TOCIO, Mary Ann | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | Usa | Usa | 177507090001 | |||||
| USSY, David | Geschäftsführer | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | Usa | Usa | 169819280001 | |||||
| WHITLAM, Paul | Geschäftsführer | Millmoor 18 Drayhorse Drive GU19 5RF Bagshot Surrey | British | 47737380001 |
Hat CASTERBRIDGE NURSERIES (HH) LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Accession deed to intercreditor deed | Erstellt am 06. Juni 2005 Geliefert am 16. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company agrees to become a party to and be bound by the intercreditor deed as an obligor, will upon demand by the security trustee pay an amount equal to the amount of all payments or distributions of or in respect of any junior liablities in cash or in kind;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed | Erstellt am 06. Juni 2005 Geliefert am 16. Juni 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 1) l/h property k/a the old toll house and the new toll house, sandown park, esher, surrey, 2) l/h property k/a the green, frimley green, surrey GU16 6HF, 3) l/h property k/a rushmoor independent school, 40 reading road, farnborough, see form 395 for other properties charged; and any interest in any other land, all shares and all related distribution rights;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Jan. 2003 Geliefert am 08. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a hatton hill day nursery 40 reading road farnborough hampshire GU14 6NB. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Jan. 2003 Geliefert am 08. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a hatton hill day nursery 1 the green frimley green camberley surrey GU16 6HF. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Nov. 2002 Geliefert am 17. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that leasehold property known as hatton hill day nursery hatton hill windlesham surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Nov. 2002 Geliefert am 17. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that leashold property known as land and premises situate at and known at the old toll house and the new toll house sandown park surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Nov. 2002 Geliefert am 17. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0