ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED

ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03303086
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    • Herstellung von Metallkonstruktionen und Teilen von Konstruktionen (25110) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Dalton Airfield
    Industrial Estate Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    North Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ATLAS WARD STRUCTURES LIMITED14. Feb. 199714. Feb. 1997
    KINGSPAN STRUCTURES LIMITED10. Jan. 199710. Jan. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 07. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014

    7 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Alan David Dunsmore am 30. Mai 2014

    2 SeitenCH01

    Ernennung von James Richard Gordon Martindale als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nigel Pickard als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 10. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Peter Emerson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. März 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    7 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Simon Peter Barnes am 01. Nov. 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Nigel Pickard am 01. Nov. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    9 SeitenAA

    Ernennung von Darrell Ward als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Alan David Dunsmore als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Peter Davison als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Peter Davison als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    10 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WARD, Darrell
    Industrial Estate Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Industrial Estate Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield
    North Yorkshire
    United Kingdom
    162903900001
    BARNES, Simon Peter
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector73812400001
    DUNSMORE, Alan David
    Industrial Estate Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Industrial Estate Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector157389760001
    MARTINDALE, James Richard Gordon
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector110076240001
    ALLY, Bibi Rahima
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    Sekretär
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    British38963210007
    DAVISON, Peter Jeffrey
    Sheraton Park
    Blackwell
    DL3 8QY Darlington
    County Durham
    Sekretär
    Sheraton Park
    Blackwell
    DL3 8QY Darlington
    County Durham
    British17502280003
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    Sekretär
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    IrishDirector145024250001
    REYNOLDS, Pamela
    The Mount
    Quarry Hill
    HX6 3BQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Sekretär
    The Mount
    Quarry Hill
    HX6 3BQ Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    BritishAccountant91736390004
    SYLVESTER, Graham
    Woodcote,
    Coulton, Hovingham
    YO62 4NE York
    North Yorkshire
    Sekretär
    Woodcote,
    Coulton, Hovingham
    YO62 4NE York
    North Yorkshire
    British66711190001
    WYATT, Ian Edward Andrew
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    Sekretär
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    BritishFinance Director9514330002
    WYATT, Ian Edward Andrew
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    Sekretär
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    BritishFinance Director9514330002
    ANDERSON, Kenneth
    The Cottage
    12 Hay Lane
    YO13 0SP Scalby
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Cottage
    12 Hay Lane
    YO13 0SP Scalby
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director151458410001
    COLLETT, Brian
    10 Norwich Street
    EC4A 1BD London
    Geschäftsführer
    10 Norwich Street
    EC4A 1BD London
    BritishCompany Director32267100001
    CRIMMINS, Mark
    11 Lightfoots Close
    YO12 5NR Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    11 Lightfoots Close
    YO12 5NR Scarborough
    North Yorkshire
    IrishCompany Director51812810001
    DAVISON, Peter Jeffrey
    Sheraton Park
    Blackwell
    DL3 8QY Darlington
    County Durham
    Geschäftsführer
    Sheraton Park
    Blackwell
    DL3 8QY Darlington
    County Durham
    EnglandBritishDirector17502280003
    EMERSON, Peter Arthur
    Linden House
    Southwell Road Kirklington
    NG22 8NF Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Linden House
    Southwell Road Kirklington
    NG22 8NF Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector14955940002
    GOLDBERG, Thomas Guy
    Catlaine Manor North Cattleholmes
    Wansford
    YO25 8NW Driffield
    Geschäftsführer
    Catlaine Manor North Cattleholmes
    Wansford
    YO25 8NW Driffield
    United KingdomBritishDirector73445850001
    HAMILTON, Thomas Robertson
    Broadacres 13 Earswick Chase
    Old Earswick
    YO32 9FZ York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Broadacres 13 Earswick Chase
    Old Earswick
    YO32 9FZ York
    North Yorkshire
    BritishDirector80213780003
    LEVINE, Peter Michael
    Alpenstrasse 15.
    Postfach 4853, C/O Refidar Moore
    Stephens
    Zug Ch6304
    Switzerland
    Geschäftsführer
    Alpenstrasse 15.
    Postfach 4853, C/O Refidar Moore
    Stephens
    Zug Ch6304
    Switzerland
    BritishDirector110141340002
    MCCARTHY, Eoin
    Cabra
    Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    Geschäftsführer
    Cabra
    Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    IrishDirector21221020001
    MULVIHILL, Dermot
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    Geschäftsführer
    Cloverhill
    Balrath Road
    Kells
    Meath
    Ireland
    IrelandIrishDirector145024250001
    MURTAGH, Brendan
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    Geschäftsführer
    Dunheeda
    IRISH Kingscourt
    Co.Cavan
    Ireland
    IrishDirector30924190002
    MURTAGH, Eugene
    Lios Na Carraige
    IRISH Kingscourt
    Cavan
    Republic Of Ireland
    Geschäftsführer
    Lios Na Carraige
    IRISH Kingscourt
    Cavan
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishDirector16536550001
    PICKARD, Nigel
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dalton
    YO7 3JN Thirsk
    Dalton Airfield Industrial Estate
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector78976080001
    RHEINHARDT, Rolf
    Nibelungenring 23
    Stutensee
    FOREIGN 76297 Germany
    Geschäftsführer
    Nibelungenring 23
    Stutensee
    FOREIGN 76297 Germany
    GermanGeneral Manager53912100001
    SEVERS, John Leslie
    Holme House Farm
    Raisbeck
    CA10 3SG Penrith
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Holme House Farm
    Raisbeck
    CA10 3SG Penrith
    Cumbria
    EnglandBritishDirector5333970003
    WYATT, Ian Edward Andrew
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    30 Deepdale Avenue
    YO11 2UF Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director9514330002

    Hat ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 15. Mai 1997
    Geliefert am 28. Mai 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land and buildings at sherburn malton north yorkshire fixed charge all buildings and other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property, assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies, fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Debenture
    Erstellt am 15. Mai 1997
    Geliefert am 28. Mai 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Juli 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Debenture
    Erstellt am 15. Mai 1997
    Geliefert am 17. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any person who is designated a lender under the loan agreement dated 15TH may 1997 pursuant to a deed of guarantee and indemnity dated 15TH may 1997
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Plcacting for Itself and as Security Trustee on Behalf of the Lenders (As Defined)
    Transaktionen
    • 17. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 10. Juli 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 15. Mai 1997
    Geliefert am 17. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and any person who is designated a lender under a loan agreement dated 15TH may 1997 pursuant to a deed of guarantee and indemnity dated 15TH may 1997
    Kurze Angaben
    L/H property k/a land and buildings at sherburn malton north yorkshire with all buildings and fixtures fixed plant and machinery and the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • 3I Plcacting for Itself and as Security Trustee on Behalf of the Lenders (As Defined)
    Transaktionen
    • 17. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0