ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03303086 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
- Herstellung von Metallkonstruktionen und Teilen von Konstruktionen (25110) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Dalton Airfield Industrial Estate Dalton YO7 3JN Thirsk North Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ATLAS WARD STRUCTURES LIMITED | 14. Feb. 1997 | 14. Feb. 1997 |
KINGSPAN STRUCTURES LIMITED | 10. Jan. 1997 | 10. Jan. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alan David Dunsmore am 30. Mai 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von James Richard Gordon Martindale als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nigel Pickard als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Emerson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. März 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon Peter Barnes am 01. Nov. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nigel Pickard am 01. Nov. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Darrell Ward als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan David Dunsmore als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Davison als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Davison als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARD, Darrell | Sekretär | Industrial Estate Dalton YO7 3JN Thirsk Dalton Airfield North Yorkshire United Kingdom | 162903900001 | |||||||
BARNES, Simon Peter | Geschäftsführer | Dalton YO7 3JN Thirsk Dalton Airfield Industrial Estate North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 73812400001 | ||||
DUNSMORE, Alan David | Geschäftsführer | Industrial Estate Dalton YO7 3JN Thirsk Dalton Airfield North Yorkshire United Kingdom | England | British | Director | 157389760001 | ||||
MARTINDALE, James Richard Gordon | Geschäftsführer | Dalton YO7 3JN Thirsk Dalton Airfield Industrial Estate North Yorkshire United Kingdom | England | British | Director | 110076240001 | ||||
ALLY, Bibi Rahima | Sekretär | Norwich Street EC4A 1BD London 10 | British | 38963210007 | ||||||
DAVISON, Peter Jeffrey | Sekretär | Sheraton Park Blackwell DL3 8QY Darlington County Durham | British | 17502280003 | ||||||
MULVIHILL, Dermot | Sekretär | Cloverhill Balrath Road Kells Meath Ireland | Irish | Director | 145024250001 | |||||
REYNOLDS, Pamela | Sekretär | The Mount Quarry Hill HX6 3BQ Sowerby Bridge West Yorkshire | British | Accountant | 91736390004 | |||||
SYLVESTER, Graham | Sekretär | Woodcote, Coulton, Hovingham YO62 4NE York North Yorkshire | British | 66711190001 | ||||||
WYATT, Ian Edward Andrew | Sekretär | 30 Deepdale Avenue YO11 2UF Scarborough North Yorkshire | British | Finance Director | 9514330002 | |||||
WYATT, Ian Edward Andrew | Sekretär | 30 Deepdale Avenue YO11 2UF Scarborough North Yorkshire | British | Finance Director | 9514330002 | |||||
ANDERSON, Kenneth | Geschäftsführer | The Cottage 12 Hay Lane YO13 0SP Scalby North Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 151458410001 | ||||
COLLETT, Brian | Geschäftsführer | 10 Norwich Street EC4A 1BD London | British | Company Director | 32267100001 | |||||
CRIMMINS, Mark | Geschäftsführer | 11 Lightfoots Close YO12 5NR Scarborough North Yorkshire | Irish | Company Director | 51812810001 | |||||
DAVISON, Peter Jeffrey | Geschäftsführer | Sheraton Park Blackwell DL3 8QY Darlington County Durham | England | British | Director | 17502280003 | ||||
EMERSON, Peter Arthur | Geschäftsführer | Linden House Southwell Road Kirklington NG22 8NF Newark Nottinghamshire | England | British | Director | 14955940002 | ||||
GOLDBERG, Thomas Guy | Geschäftsführer | Catlaine Manor North Cattleholmes Wansford YO25 8NW Driffield | United Kingdom | British | Director | 73445850001 | ||||
HAMILTON, Thomas Robertson | Geschäftsführer | Broadacres 13 Earswick Chase Old Earswick YO32 9FZ York North Yorkshire | British | Director | 80213780003 | |||||
LEVINE, Peter Michael | Geschäftsführer | Alpenstrasse 15. Postfach 4853, C/O Refidar Moore Stephens Zug Ch6304 Switzerland | British | Director | 110141340002 | |||||
MCCARTHY, Eoin | Geschäftsführer | Cabra Kingscourt Co.Cavan Ireland | Irish | Director | 21221020001 | |||||
MULVIHILL, Dermot | Geschäftsführer | Cloverhill Balrath Road Kells Meath Ireland | Ireland | Irish | Director | 145024250001 | ||||
MURTAGH, Brendan | Geschäftsführer | Dunheeda IRISH Kingscourt Co.Cavan Ireland | Irish | Director | 30924190002 | |||||
MURTAGH, Eugene | Geschäftsführer | Lios Na Carraige IRISH Kingscourt Cavan Republic Of Ireland | Ireland | Irish | Director | 16536550001 | ||||
PICKARD, Nigel | Geschäftsführer | Dalton YO7 3JN Thirsk Dalton Airfield Industrial Estate North Yorkshire United Kingdom | England | British | Director | 78976080001 | ||||
RHEINHARDT, Rolf | Geschäftsführer | Nibelungenring 23 Stutensee FOREIGN 76297 Germany | German | General Manager | 53912100001 | |||||
SEVERS, John Leslie | Geschäftsführer | Holme House Farm Raisbeck CA10 3SG Penrith Cumbria | England | British | Director | 5333970003 | ||||
WYATT, Ian Edward Andrew | Geschäftsführer | 30 Deepdale Avenue YO11 2UF Scarborough North Yorkshire | England | British | Finance Director | 9514330002 |
Hat ATLAS WARD BUILDING SYSTEMS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 15. Mai 1997 Geliefert am 28. Mai 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a land and buildings at sherburn malton north yorkshire fixed charge all buildings and other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property, assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies, fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property, floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Mai 1997 Geliefert am 28. Mai 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Mai 1997 Geliefert am 17. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and any person who is designated a lender under the loan agreement dated 15TH may 1997 pursuant to a deed of guarantee and indemnity dated 15TH may 1997 | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 15. Mai 1997 Geliefert am 17. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and any person who is designated a lender under a loan agreement dated 15TH may 1997 pursuant to a deed of guarantee and indemnity dated 15TH may 1997 | |
Kurze Angaben L/H property k/a land and buildings at sherburn malton north yorkshire with all buildings and fixtures fixed plant and machinery and the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0