X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03303903 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Gillian Elizabeth James am 31. März 2011 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Robert Charles Gale am 31. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanne Christine Tillbrook als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Mario Mackenzie als Geschäftsführer am 20. Feb. 2002 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Mario Mackenzie als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 160 Great Portland Street London W1W 5QA am 31. März 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 25 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Virgin Media Secretaries Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Virgin Media Directors Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | 151391230001 | |||||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | England | British | 96956740001 | |||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | 148 Selwyn Avenue Highams Park E4 9LS London | British | 72139660001 | ||||||
| LUBASCH, Richard Joel | Sekretär | 4 Beech Tree Lane NEW YORK Brookville 11545 Usa | British | 81075820001 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Sekretär | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | British | 47785600002 | ||||||
| PHILLIPS, Derek Norman | Sekretär | 10 Lawrence Crescent Richmond DL10 5QE Darlington North Yorkshire | British | 51107720001 | ||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| CAMPBELL, Edward Heron | Geschäftsführer | Dromonby View Dromonby House Busby Lane TS9 7AP Kirkby Cleveland | Canadian | 50976920003 | ||||||
| CARTER, Stephen Andrew | Geschäftsführer | 22 Melville Road Barnes SW13 9RJ London | United Kingdom | British | 59445920002 | |||||
| GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Station Road KT7 0NS Thames Ditton 42 Surrey | England | British | 96956740001 | |||||
| GREGG, John Francis | Geschäftsführer | 411 Silvermoss Drive Vero Beach Florida 32963 America | American | 75381740001 | ||||||
| KELHAM, David William | Geschäftsführer | Chastilian Gough Road GU51 4LJ Fleet Hampshire | England | British | 87146390001 | |||||
| KNAPP, James Barclay | Geschäftsführer | 54 Hodge Road Princeton New Jersey 08540 Usa | Us Citizen | 79688880001 | ||||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Ranelagh Avenue SW6 3PJ London 19 | United Kingdom | British | 47785600002 | |||||
| MCKELLAR, Ronald Alexander | Geschäftsführer | Halstead Stratfield Saye RG7 2EJ Reading Berkshire | British | 7345780001 | ||||||
| PHILLIPS, Derek Norman | Geschäftsführer | 10 Lawrence Crescent Richmond DL10 5QE Darlington North Yorkshire | United Kingdom | British | 51107720001 | |||||
| RICHTER, Bret | Geschäftsführer | 245 East 63rd Street Apartment 20h 10021 New York New York United States | American | 86830760001 | ||||||
| ROBERTS, Gareth Nigel Christopher | Geschäftsführer | 20 Aspen Lodge Abbots Walk W8 5UN London | British | 145824690001 | ||||||
| ROSS, Stuart | Geschäftsführer | 15 Mckay Road SW20 0HT London | England | British | 20168110001 | |||||
| SCHUBERT, Scott Elliott | Geschäftsführer | 9 William Street House William Street SW1X 9HH London | American | 89618040001 | ||||||
| TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | 164134250001 | |||||
| WOOD, Leigh | Geschäftsführer | The Priory 10 Hambledon Park Hambledon GU8 4ER Godalming Surrey | American | 53880530001 | ||||||
| VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107430002 | |||||||
| VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Hat X L DEBT RECOVERY AGENCY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Erstellt am 29. Juni 2010 Geliefert am 08. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Confirmation deed | Erstellt am 15. Apr. 2010 Geliefert am 29. Apr. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An alternative bridge composite debenture | Erstellt am 16. Juni 2006 Geliefert am 29. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 10. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Juni 2004 Geliefert am 30. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0