LEISURE WORLD (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLEISURE WORLD (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03305870
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LEISURE WORLD (UK) LIMITED?

    • (9271) /
    • (9272) /

    Wo befindet sich LEISURE WORLD (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o BAKER TILLY
    6th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LEISURE WORLD (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GALAXY GAMING LIMITED07. Sept. 200907. Sept. 2009
    LEISURE WORLD (UK) LIMITED22. Jan. 199722. Jan. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEISURE WORLD (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für LEISURE WORLD (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    31 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Dez. 2023

    30 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Dez. 2022

    30 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Dez. 2021

    28 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Dez. 2020

    27 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Dez. 2019

    24 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Dez. 2018

    24 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Dez. 2017

    23 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    26 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Juni 2016

    29 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 21. Okt. 2015

    29 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Juni 2015

    27 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Dez. 2014

    27 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Juni 2014

    28 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Apr. 2014

    29 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Dez. 2013

    28 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Juni 2013

    27 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 05. Okt. 2012

    28 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Juni 2012

    28 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Wer sind die Geschäftsführer von LEISURE WORLD (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MANN, Kiran Kaur
    32 Nascot Wood Road
    WD17 4SD Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    32 Nascot Wood Road
    WD17 4SD Watford
    Hertfordshire
    British121038930001
    CHAHAL, Jagjeet Singh
    c/o Baker Tilly
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    6th Floor
    Geschäftsführer
    c/o Baker Tilly
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    6th Floor
    EnglandBritish124923050001
    MANN, Amarjit Singh
    32 Nascot Wood Road
    WD17 4SD Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    32 Nascot Wood Road
    WD17 4SD Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish116338370001
    NIKOLAEV, Stanislav
    Julius Caesar Way
    HA7 4PZ Stanmore
    6
    Geschäftsführer
    Julius Caesar Way
    HA7 4PZ Stanmore
    6
    Bulgarian147263360001
    PANCHAL, Kamlesh
    19 Oldborough Road
    HA0 3PP North Wembley
    Middlesex
    Geschäftsführer
    19 Oldborough Road
    HA0 3PP North Wembley
    Middlesex
    United KingdomBritish44658640001
    CANAL, Ricardo Itarte
    Flat 2 47 Kempsford Gardens
    SW5 9LA London
    Sekretär
    Flat 2 47 Kempsford Gardens
    SW5 9LA London
    Spanish83149470002
    HOPSON, Martin
    42 Cricketers Close
    DE15 9EH Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    42 Cricketers Close
    DE15 9EH Burton On Trent
    Staffordshire
    British53349800002
    IBANEZ, Jorge
    103 Albert Bridge Road
    SW11 4PF London
    Sekretär
    103 Albert Bridge Road
    SW11 4PF London
    British75055960002
    JONES, Barbara
    209 Ashby Road
    DE15 0LA Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    209 Ashby Road
    DE15 0LA Burton On Trent
    Staffordshire
    British40435850001
    MOON, Timothy
    8 Greenhill Road
    Otford
    TN14 5RS Sevenoaks
    Kent
    Sekretär
    8 Greenhill Road
    Otford
    TN14 5RS Sevenoaks
    Kent
    British31985130005
    VALENTE, Anjanette
    54 Flora Thompson Drive
    MK16 8ST Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Sekretär
    54 Flora Thompson Drive
    MK16 8ST Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    British67595500002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    CANAL, Ricardo Itarte
    Flat 2 47 Kempsford Gardens
    SW5 9LA London
    Geschäftsführer
    Flat 2 47 Kempsford Gardens
    SW5 9LA London
    Spanish83149470002
    DEITH, Matthew
    Three Gables
    Ballards Lane Limpsfield
    RH8 0SN Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    Three Gables
    Ballards Lane Limpsfield
    RH8 0SN Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish90409850001
    DEITH, Robert
    353 Wimbledon Central
    SW19 4BJ 21-33 Worple Road
    Wimbledon
    Geschäftsführer
    353 Wimbledon Central
    SW19 4BJ 21-33 Worple Road
    Wimbledon
    British82893220001
    HALL, Francesca
    181 Westhall Road
    CR6 9HL Warlingham
    Surrey
    Geschäftsführer
    181 Westhall Road
    CR6 9HL Warlingham
    Surrey
    British51315190002
    HALL, Miles
    Brook Cottage
    Tandridge Lane Tandridge
    RH8 9NW Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    Brook Cottage
    Tandridge Lane Tandridge
    RH8 9NW Oxted
    Surrey
    British66168400001
    HOPSON, Martin
    8 Betony Road
    DE15 9JU Burton On Trent
    Geschäftsführer
    8 Betony Road
    DE15 9JU Burton On Trent
    United KingdomBritish53349800004
    IBANEZ, Jorge
    103 Albert Bridge Road
    SW11 4PF London
    Geschäftsführer
    103 Albert Bridge Road
    SW11 4PF London
    British75055960002
    MANN, Harjinder Singh
    32 Nascot Wood Road
    WD17 4SD Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    32 Nascot Wood Road
    WD17 4SD Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritish121038270001
    MASCARELL, Luis
    Ametller 31, Sant Quirze Del Valles
    Barcelona, 08192
    FOREIGN Spain
    Geschäftsführer
    Ametller 31, Sant Quirze Del Valles
    Barcelona, 08192
    FOREIGN Spain
    Spanish67668400001
    MOON, Timothy
    8 Greenhill Road
    Otford
    TN14 5RS Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    8 Greenhill Road
    Otford
    TN14 5RS Sevenoaks
    Kent
    British31985130005
    MORETON, Henry Charles
    16 Guildhall Drive
    Selston
    NG16 6GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    16 Guildhall Drive
    Selston
    NG16 6GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British76435880001
    PAPOUROV, George Ganchev
    10 Gatliff Road
    SW1W 8QL London
    Appt 71 Cubitt Building
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    10 Gatliff Road
    SW1W 8QL London
    Appt 71 Cubitt Building
    United Kingdom
    BulgariaBulgarian135852820001
    TOMAS, Martin Tomas
    C/ Casanovas I Bosch 54 3
    Sabadell
    Catalonia 08202
    Spain
    Geschäftsführer
    C/ Casanovas I Bosch 54 3
    Sabadell
    Catalonia 08202
    Spain
    Spanish79326890001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Hat LEISURE WORLD (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Floating charge
    Erstellt am 29. Sept. 2009
    Geliefert am 15. Okt. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Floating charge over undertaking & all property & assets including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Boliari Ead
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 13. Nov. 2008
    Geliefert am 19. Nov. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from ablethird limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of ablethird limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a ground floor of 197/199 trafalgar road, london and l/h property k/a 1 and 3 fish street and 36 abington street northampton including all buildings, erections and fixtures and fittings (but excluding tenants fixtures and fittings) and fixed plant, equipment, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transaktionen
    • 19. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    3RD party mortgage debenture
    Erstellt am 25. Apr. 2007
    Geliefert am 09. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and/or company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    54 station road, redhill t/no SY697090. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    92 high street, new malden. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    62 high street, croydon t/no SGL620015. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    31/33 church street, croydon t/no SGL569602. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    75/75A high street, tonbridge t/no K622943. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    30 high street, ashford, kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    73 southchurch road, southend-on-sea. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 63 high street, bromley, kent. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 12. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 12. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 73 southchurch road southend on sea essex.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 12. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 31-33 church street croydon surrey t/n SGL569602.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 12. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 62 high street croydon surrey t/n SGL620015.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 12. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 92 high street new malden.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 12. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 54 station road redhill surrey.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 12. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 30 high street ashford kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 12. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 63 high street bromley kent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 12. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 75 and 75A high street tonbridge t/n K622943.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rental deposit deed
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 07. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Deposit of £14,000 held by mortgagee.
    Berechtigte Personen
    • Trans-World Investments Limited
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 31. Mai 2000
    Geliefert am 08. Juni 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a lease dated 29TH december 1995 and made between the cooperative wholesale limited (1) wilson fun company limited (2) as varied by a deed of variation
    Kurze Angaben
    £6500 held in a seperate account at hsbc bank PLC.
    Berechtigte Personen
    • Betterkey Limited
    Transaktionen
    • 08. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Mai 2000
    Geliefert am 08. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    75/75A high street tonbridge t/n K622943 together with all buildings fixtures fixtures fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • Ruffler Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Mai 2000
    Geliefert am 08. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Shop and premises 73 southchurch road southend-on-sea together with all buildings fixtures fixtures fixed plant and machinery thereon.
    Berechtigte Personen
    • Ruffler Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat LEISURE WORLD (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Dez. 2009Beginn der Verwaltung
    09. Dez. 2016Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Paul Hudson
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praktiker
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Graham Paul Bushby
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praktiker
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Simon Peter Bower
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praktiker
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Bruce Alexander Mackay
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praktiker
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    2
    DatumTyp
    09. Dez. 2016Beginn der Liquidation
    03. Juli 2024Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Graham Paul Bushby
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Vorgeschlagener Liquidator
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Bruce Alexander Mackay
    9th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Vorgeschlagener Liquidator
    9th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Bruce Alexander Mackay
    9th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praktiker
    9th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Graham Paul Bushby
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praktiker
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0