PUCKRUP HALL HOTEL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePUCKRUP HALL HOTEL LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03307736
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PUCKRUP HALL HOTEL LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich PUCKRUP HALL HOTEL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PUCKRUP HALL HOTEL LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2025
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2026
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2024

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für PUCKRUP HALL HOTEL LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis01. Dez. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung15. Dez. 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis01. Dez. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für PUCKRUP HALL HOTEL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2024

    28 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Hilton Uk Corporate Director Limited als Geschäftsführer am 11. Feb. 2025

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Kimberly Jane Coari als Geschäftsführer am 04. Okt. 2024

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023

    29 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    30 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Kimberly Jane Coari am 01. März 2021

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Robert Vincent am 01. Aug. 2014

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Brian Mckay Wilson am 31. Okt. 2022

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Brian Mckay Wilson am 03. Okt. 2022

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    30 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr George Christopher Ogle am 28. Jan. 2022

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Geoffrey Beeston am 24. Juni 2021

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    31 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    31 SeitenAA

    Change of details for Hilton Worldwide Limited as a person with significant control on 28. Aug. 2020

    2 SeitenPSC05

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Kimberly Jane Coari als Direktor am 19. Dez. 2019

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    28 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von PUCKRUP HALL HOTEL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HLT SECRETARY LIMITED
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    125128960001
    BEASLEY, Stuart
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish188237620002
    BEESTON, Richard Geoffrey
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Geschäftsführer
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    United KingdomBritish242993840002
    CASSIDY, Stephen Patrick
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Geschäftsführer
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    United KingdomBritish243441390001
    MOMDJIAN, Michelle
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Geschäftsführer
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    United KingdomBritish253271050001
    OGLE, George Christopher
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Geschäftsführer
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    United KingdomBritish253271070002
    PERCIVAL, James Owen
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish161274380001
    VINCENT, Simon Robert
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish102638930017
    WILSON, Brian Mckay
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish125151140005
    ALLY, Bibi Rahima
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    Sekretär
    60 Harbury Road
    SM5 4LA Carshalton Beeches
    Surrey
    British38963210003
    HUGHES, Barbara
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    Sekretär
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    British45702460001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Sekretär
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    PENDRILL, Richard William
    Boscobel Sweetwater Lane
    Wormley
    GU8 5SS Godalming
    Surrey
    Sekretär
    Boscobel Sweetwater Lane
    Wormley
    GU8 5SS Godalming
    Surrey
    British5919770001
    WILSON, Brian
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    Sekretär
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    British125151140001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    BRADLEY, Adrian Paul
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish90379240002
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Geschäftsführer
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    COARI, Kimberly Jane
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish265529150002
    ENAYETULLAH, Habib Mohammed
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    Geschäftsführer
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Herts
    United KingdomAmerican185147300001
    FRIEDMAN, Howard
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Usa106914780001
    GOSLING, Peter Charles
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    Geschäftsführer
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    EnglandEnglish142633640001
    HARRIS, Anthony Richard
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    Geschäftsführer
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    British64357620006
    HARVEY, Paul Victor
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    British116809270001
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritish88628480001
    HEATH, Christopher Philip
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    United Kingdom
    EnglandBritish205835660001
    HOWARD, Robin Ivan
    Broadacre House
    Coningsby Lane, Fifield
    SL6 2PF Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Broadacre House
    Coningsby Lane, Fifield
    SL6 2PF Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish,2570730002
    HUGHES, Andrew Lawrence
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish109749210001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    British143730250001
    HUMPHREYS, Stephen
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    British71438830004
    JAMES, Paul Frederick
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    British48791500001
    LICHMAN, Laurence
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    British143730380001
    LIFSCHITZ, Oded
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    Geschäftsführer
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    United KingdomAustralian / Israeli172992020002
    LIFSCHITZ, Oded
    225 Edgware Road
    W2 1JU London
    C/O Hilton London Metropole Hotel
    England
    England
    Geschäftsführer
    225 Edgware Road
    W2 1JU London
    C/O Hilton London Metropole Hotel
    England
    England
    United KingdomAustralian / Israeli172992020001
    LYLE, Gordon William
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish143730330001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Geschäftsführer
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PUCKRUP HALL HOTEL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    West George Street
    G2 2LD Glasgow
    191
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    West George Street
    G2 2LD Glasgow
    191
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandScotland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    RegistrierungsnummerSc022163
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0