PCV HP NOMINEE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePCV HP NOMINEE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03309232
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PCV HP NOMINEE LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FREEHOLD PORTFOLIOS HP NOMINEE LIMITED23. Jan. 199723. Jan. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2018

    6 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2017

    6 SeitenLIQ03

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2016

    4 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:court order - removal/ replacement of liquidator
    30 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2015

    4 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB zum 15 Canada Square London E14 5GL am 17. Okt. 2015

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ zum 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB am 16. Okt. 2014

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    7 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 23. Sept. 2014

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 08. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 17. Sept. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 17. Sept. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    6 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von PCV HP NOMINEE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Australian57113450003
    GROSE, David Leonard
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House
    Geschäftsführer
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House
    United KingdomBritish120479020002
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritish6815470021
    MOUSLEY, Emily Ann
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    Geschäftsführer
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    United KingdomBritish155262770001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    LINEOBTAIN LIMITED
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    Sekretär
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    87536870003
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritish100504300001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Geschäftsführer
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritish108586450001
    EVANS, Alasdair David
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    Geschäftsführer
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    United KingdomBritish130019430001
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    British33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    Geschäftsführer
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    British93017010002
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Geschäftsführer
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritish38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Geschäftsführer
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritish4779170003
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Hat PCV HP NOMINEE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental debenture
    Erstellt am 28. März 2003
    Geliefert am 15. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All shares held by the company and/or any nominee on it's behalf and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft London Branch,(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 2001
    Geliefert am 02. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    All that f/h land k/a 35 broad street and 29-31 queen victoria street,reading title absolute under t/n BK115467. For further details of all property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, as Agent and Trustee Tothe Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 18TH february 2000 and
    Erstellt am 09. Feb. 2000
    Geliefert am 29. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as freehold portfolios hp nominee limited) and/or any other obligor to each senior finance party under each senior finance document or each mezzanine finance party under each mezzanine finance document
    Kurze Angaben
    All and whole those shop premises with ancillary office accommodation on the basement, ground and first floors in the burgh of falkirk and county of stirling now k/a numbers 118 to 120 high street falkirk t/no STG10222. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank as Agent and Trusteefor Itself and the Other Finance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 29. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture between the company (formerly known as freehold portfolios hp nominee limited) each chargor and the security trustee
    Erstellt am 09. Feb. 2000
    Geliefert am 21. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whather actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to a). Each senior finance party under each senior finance document; or b). Each mezzanine finance party under each mezzanine finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985.
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutchen Bank, London Branch(As Agent and Trustee for the Senior Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties)
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 09. Feb. 2000
    Geliefert am 19. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to each senior finance party under each senior finance document or each mazzanine finance party under each mezzanine finance document (all defined therein)
    Kurze Angaben
    Right, title and interest in and to the rental income in respect of the subjects (as defined).
    Berechtigte Personen
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank, London Branch, Asagent and Trustee for Itself and the Other Finance Parties ("the Security Trustee")
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security dated 05 july 1999 which was registered in scotland on 12 july 1999
    Erstellt am 12. Juli 1999
    Geliefert am 28. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or each other borrower to the agent as lender, agent one of the arrangers and original counterparty and its successors and assignees whomsoever and to each other finance party under or pursuant to a credit agreement dated 05 july 1999
    Kurze Angaben
    Property k/a numbers one hundred and eighteen to one hundred and twenty high street falkirk t/n stg 10222.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and the Other Financeparties
    Transaktionen
    • 28. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 07. Juli 1999
    Geliefert am 15. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The companys right, title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement).
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag
    Transaktionen
    • 15. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Juli 1999
    Geliefert am 20. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies whatsoever due or to become due from each borrower (as defined) and fp financial to each finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft,London Branch,as Agent and Trustee for Thefinance Parties
    Transaktionen
    • 20. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 14. Jan. 1999
    Geliefert am 26. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and the other finance parties (as defined in the credit agreement dated 21ST october 1998) under or pursuant to the credit agreement and any finance document referred to as such in the credit agreement
    Kurze Angaben
    The company's right title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement) payable in respect of the leases of the subjects.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Ag
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Jan. 1999
    Geliefert am 19. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined)under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    16 toll gavel beverley 33 parliament street york f/h property k/a 35 broad street and 29-31 queen victoria street reading t/nos: HS200862 NYK127042 BK115467 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 25 january 1999 and
    Erstellt am 05. Jan. 1999
    Geliefert am 30. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or each other borrower (as defined) under or pursuant to a credit agreement dated 21 october 1998
    Kurze Angaben
    The property known as 118 to 120 high street falkirk title number STG10222.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag as Agent and Trustee for Itself and Theother Finance Parties ("Agent")
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 04. Feb. 1997
    Geliefert am 20. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The properties being 189 high street, southend on sea-EX166546 and the other properties described on the schedule attached to the form M395 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fittings thereon, rights, licences, leases and a floating charge over the property, assets, rights and revenues including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 04. Feb. 1997
    Geliefert am 20. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By clause 2 of the assignment all the right, titles, benefits and interests to all monies owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of 189 high street, southend on sea-EX166546 and all the other properties described in the schedule attached to the form M395. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PCV HP NOMINEE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Feb. 2019Aufgelöst am
    23. Sept. 2014Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0