PCV HP NOMINEE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PCV HP NOMINEE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03309232 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PCV HP NOMINEE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PCV HP NOMINEE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PCV HP NOMINEE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FREEHOLD PORTFOLIOS HP NOMINEE LIMITED | 23. Jan. 1997 | 23. Jan. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PCV HP NOMINEE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PCV HP NOMINEE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2018 | 6 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2017 | 6 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:secretary of state's release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2016 | 4 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:court order - removal/ replacement of liquidator | 30 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Sept. 2015 | 4 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB zum 15 Canada Square London E14 5GL am 17. Okt. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ zum 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB am 16. Okt. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 17. Sept. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 17. Sept. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PCV HP NOMINEE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUMM, Sandra Louise | Sekretär | Canada Square E14 5GL London 15 | Australian | 57113450003 | ||||||
| GROSE, David Leonard | Geschäftsführer | 18 Cavendish Square W1G 0PJ London Cavendish House | United Kingdom | British | 120479020002 | |||||
| GUMM, Sandra Louise | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | England | Australian | 57113450003 | |||||
| LESLAU, Nicholas Mark | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | British | 6815470021 | |||||
| MOUSLEY, Emily Ann | Geschäftsführer | Flat C, 1 Cranley Gardens, Muswell Hill N10 3AA London | United Kingdom | British | 155262770001 | |||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| LINEOBTAIN LIMITED | Sekretär | Mountcliff House 154 Brent Street NW4 2DR London | 87536870003 | |||||||
| BRADY, James Michael | Geschäftsführer | 1 Cromwell Close AL4 9YE St Albans Hertfordshire | England | British | 3769730001 | |||||
| BURROWES, David William | Geschäftsführer | 60 Westwater Way OX11 7TY Didcot Oxfordshire | United Kingdom | British | 100504300001 | |||||
| EAST, Stephen John | Geschäftsführer | White Ladies Birch Hill Shirley Hills CR0 5HT Surrey | England | British | 108586450001 | |||||
| EVANS, Alasdair David | Geschäftsführer | 8 Copsem Lane KT10 9EU Esher Treaton Mill Surrey | United Kingdom | British | 130019430001 | |||||
| HARROLD, Richard Anthony | Geschäftsführer | Hill House Farm Brandon Parva NR9 4DL Norwich Norfolk | British | 33048780001 | ||||||
| LEWIS, Gavin Andrew | Geschäftsführer | 10 Penners Gardens KT6 6JW Surbiton Surrey | British | 93017010002 | ||||||
| RITBLAT, James William Jeremy | Geschäftsführer | 24 St Petersburgh Place W2 4LB London | England | British | 38424950003 | |||||
| WAGMAN, Colin Barry | Geschäftsführer | North Lodge 25 Ringwood Avenue N2 9NT London | United Kingdom | British | 39329840001 | |||||
| WARE, Robert Thomas Ernest | Geschäftsführer | Woodley Lodge Duffield Road RG5 4RL Woodley Berkshire | United Kingdom | British | 4779170003 | |||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Hat PCV HP NOMINEE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental debenture | Erstellt am 28. März 2003 Geliefert am 15. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All shares held by the company and/or any nominee on it's behalf and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 2001 Geliefert am 02. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to each finance party under each finance document (all terms as defined) | |
Kurze Angaben All that f/h land k/a 35 broad street and 29-31 queen victoria street,reading title absolute under t/n BK115467. For further details of all property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 18TH february 2000 and | Erstellt am 09. Feb. 2000 Geliefert am 29. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as freehold portfolios hp nominee limited) and/or any other obligor to each senior finance party under each senior finance document or each mezzanine finance party under each mezzanine finance document | |
Kurze Angaben All and whole those shop premises with ancillary office accommodation on the basement, ground and first floors in the burgh of falkirk and county of stirling now k/a numbers 118 to 120 high street falkirk t/no STG10222. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture between the company (formerly known as freehold portfolios hp nominee limited) each chargor and the security trustee | Erstellt am 09. Feb. 2000 Geliefert am 21. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whather actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to a). Each senior finance party under each senior finance document; or b). Each mezzanine finance party under each mezzanine finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985. | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents | Erstellt am 09. Feb. 2000 Geliefert am 19. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of each obligor to each senior finance party under each senior finance document or each mazzanine finance party under each mezzanine finance document (all defined therein) | |
Kurze Angaben Right, title and interest in and to the rental income in respect of the subjects (as defined). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security dated 05 july 1999 which was registered in scotland on 12 july 1999 | Erstellt am 12. Juli 1999 Geliefert am 28. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or each other borrower to the agent as lender, agent one of the arrangers and original counterparty and its successors and assignees whomsoever and to each other finance party under or pursuant to a credit agreement dated 05 july 1999 | |
Kurze Angaben Property k/a numbers one hundred and eighteen to one hundred and twenty high street falkirk t/n stg 10222. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents | Erstellt am 07. Juli 1999 Geliefert am 15. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The companys right, title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Juli 1999 Geliefert am 20. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies whatsoever due or to become due from each borrower (as defined) and fp financial to each finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents | Erstellt am 14. Jan. 1999 Geliefert am 26. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and the other finance parties (as defined in the credit agreement dated 21ST october 1998) under or pursuant to the credit agreement and any finance document referred to as such in the credit agreement | |
Kurze Angaben The company's right title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement) payable in respect of the leases of the subjects. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Jan. 1999 Geliefert am 19. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined)under each finance document (as defined) and on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 16 toll gavel beverley 33 parliament street york f/h property k/a 35 broad street and 29-31 queen victoria street reading t/nos: HS200862 NYK127042 BK115467 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on the 25 january 1999 and | Erstellt am 05. Jan. 1999 Geliefert am 30. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or each other borrower (as defined) under or pursuant to a credit agreement dated 21 october 1998 | |
Kurze Angaben The property known as 118 to 120 high street falkirk title number STG10222. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 04. Feb. 1997 Geliefert am 20. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The properties being 189 high street, southend on sea-EX166546 and the other properties described on the schedule attached to the form M395 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fittings thereon, rights, licences, leases and a floating charge over the property, assets, rights and revenues including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment by way of charge | Erstellt am 04. Feb. 1997 Geliefert am 20. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By clause 2 of the assignment all the right, titles, benefits and interests to all monies owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of 189 high street, southend on sea-EX166546 and all the other properties described in the schedule attached to the form M395. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PCV HP NOMINEE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0