TRINITY CARE (HOVE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRINITY CARE (HOVE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03309676
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRINITY CARE (HOVE) LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich TRINITY CARE (HOVE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TRINITY CARE (HOVE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TRINITY CARE HOMES NO 2 LIMITED 02. Mai 199702. Mai 1997
    AYCEECO (144) LIMITED29. Jan. 199729. Jan. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRINITY CARE (HOVE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRINITY CARE (HOVE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012

    1 SeitenTM02

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. Jan. 2012

    Kapitalaufstellung am 31. Jan. 2012

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    28 SeitenAA

    Ernennung von Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Enter agreements 14/05/2010
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009

    25 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung eines Direktors

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Richard Neil Midmer am 27. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von TRINITY CARE (HOVE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British84003280001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158661900001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Sekretär
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    WATTS, Philip
    3 Waring Close
    Princes End
    DY4 9NW Tipton
    West Midlands
    Sekretär
    3 Waring Close
    Princes End
    DY4 9NW Tipton
    West Midlands
    British51121340001
    ARTHUR, Kevin Mccabe
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    Geschäftsführer
    The Landings
    Beningbrough
    YO30 1BY York
    British51886750002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DALLING, Stephen James
    91 Kempson Avenue
    B72 1HF Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    91 Kempson Avenue
    B72 1HF Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish141721320001
    FARMER, Nicholas John
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    62 Freshwater Close
    Great Sankey
    WA5 3PU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish124228290001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GEE, Andrew Anthony Edward
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    Geschäftsführer
    83a Sutherland Avenue
    TN16 3HG Biggin Hill
    Kent
    EnglandBritish93592160001
    GOODALL, Christopher John
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    4 Manor Court
    Bramcote
    NG9 3DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish84003280001
    HENDERSON, David Greig
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    Geschäftsführer
    20 Lydney Park
    West Bridgford
    NG2 7TJ Nottingham
    EnglandBritish6112570002
    HILL, Randolph Paul
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    40 Bridgetown Road
    CV37 7JA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British15223790003
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MARK, Larry Edward
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    Geschäftsführer
    29 Cedar Drive
    SL5 0UA Sunningdale
    Berkshire
    New Zealander5076900001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MORETON, John Ernest
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Old Farm
    Winkfield Row
    RG12 6NG Reading
    Berkshire
    New Zealander80392940001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Geschäftsführer
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Geschäftsführer
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    PRESTON, Mary
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    Geschäftsführer
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    United KingdomBritish124068010001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Geschäftsführer
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Geschäftsführer
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SUFFIELD, Mervyn John, Dr
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Cottage Winchester Road
    Waltham Chase
    SO32 2LG Southampton
    Hampshire
    British34214100001
    THORNE, Anthony David
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    Geschäftsführer
    41 Bartholomew Place
    RG42 3DQ Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritish80445640001
    WATTS, Philip
    3 Waring Close
    Princes End
    DY4 9NW Tipton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    3 Waring Close
    Princes End
    DY4 9NW Tipton
    West Midlands
    EnglandBritish51121340001

    Hat TRINITY CARE (HOVE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. Feb. 2008
    Geliefert am 14. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 14. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 19. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 19. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Juli 2006
    Geliefert am 20. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 20. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Apr. 2005
    Geliefert am 15. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 2004
    Geliefert am 28. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2002
    Geliefert am 03. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transaktionen
    • 03. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third guarantee and debenture
    Erstellt am 16. Mai 2002
    Geliefert am 30. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the chargor and by each other charging company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second guarantee and debenture
    Erstellt am 25. Feb. 2002
    Geliefert am 11. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the chargor and by each other charging company to the chargee (as security agent for the beneficiaries) (as defined) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TRINITY CARE (HOVE) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    20. Aug. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Praktiker
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0