140 PARK LANE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    Unternehmensname140 PARK LANE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03312458
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von 140 PARK LANE LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich 140 PARK LANE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    179 Great Portland Street
    London
    W1W 5LS
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von 140 PARK LANE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PARTYCORP LIMITED04. Feb. 199704. Feb. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 140 PARK LANE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für 140 PARK LANE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 02. Feb. 2011

    • Kapital: GBP 1,276.70
    4 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenSH20

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancel share prem a/c 31/12/2010
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Rücktritt des Auditors

    5 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    16 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Andrew Blurton als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    16 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew Francis Blurton am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ms Gail Robson am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    17 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    18 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    20 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2005

    20 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von 140 PARK LANE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROBSON, Gail
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    British100895090001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Sekretär
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    MA, Philip King Huen
    A1 7/F South Bay Garden
    33 South Bay Close
    FOREIGN Hong Kong
    Geschäftsführer
    A1 7/F South Bay Garden
    33 South Bay Close
    FOREIGN Hong Kong
    Hong KongCanadian36532980002
    ABOGADO CUSTODIANS LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021140001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    Bevollmächtigter Sekretär
    Leonard Street
    EC2A 4QS London
    83
    900013740001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Geschäftsführer
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish53724380001
    MA, Walter King Wah
    18 Blacks Link
    Hong Kong
    Geschäftsführer
    18 Blacks Link
    Hong Kong
    Hong KongAustralian36532930001
    SINGH, Jagtar
    6 Paines Lane
    HA5 3DQ Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    6 Paines Lane
    HA5 3DQ Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish121710890001
    ABOGADO CUSTODIANS LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021140001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    900021150001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    Hat 140 PARK LANE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of debenture
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 13. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any of them) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property 140 park lane and 535 to 539 oxford street london t/n 420074. l/h property part of basement and ground and first floors 527 to 533 (odd numbers) oxford street and 68 to 70 north row and the airspace abovet/n NGL784069. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank Scotland (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Security interest agreement
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 13. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the finance parties
    Kurze Angaben
    Assigns title to the collateral being the shares in flatford limited including all derivative assets and all the company's right title and interest from time to time in all such securities and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank Scotland (The Agent)
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Security interest agreement
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 13. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the finance parties
    Kurze Angaben
    Assigns title to the collateral being the shares in flatford (no. 2) limited including all derivative assets and all the company's right title and interest from time to time in all such securities and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank Scotland (The Agent)
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Jan. 2002
    Geliefert am 25. Jan. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of second legal mortgage the mortgaged property and shares, by way of assignment A. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Marriott Hotels Limited
    Transaktionen
    • 25. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Security interest agreement
    Erstellt am 08. Jan. 2002
    Geliefert am 11. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each of the finance documents as defined in the credit agreement
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the securities being £10 ordinary shares of £1 each issued in the share capital of flatford limited together with all securities accruing therefrom (inclusive of devidends interest and other income). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security interest agreement
    Erstellt am 08. Jan. 2002
    Geliefert am 11. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each of the finance documents as defined in the credit agreement
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to the securities being 10 ordinary shares of £1 each issued in the share capital of flatford (no.2) limited and all securities deriving therefrom (inclusive of dividends interest and other income). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party general security assignment
    Erstellt am 08. Jan. 2002
    Geliefert am 10. Jan. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from 140 park lane (no.3) limited (as borrower) to the bank
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to a £7,000,000 secured subordinated loan agreement dated 7TH january 2002 between the chargor flatford limited and flatford (no.2) limited international hotel licencing S.A.R.L. marriott international inc. And marylebone balfour group PLC.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 26. Feb. 2001
    Geliefert am 14. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to clause 5.3 (guaranty payment) of the management agreement of even date or the debenture
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a 140 park lane and 535 to 539 oxford street london W1 t/no: 420074 land and buildings being part basement ground and first floors of maryon house 527 to 533 (odd numbers) oxford street and 68 to 70 north row london W1 with the air space thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Marriott Hotels Limited
    Transaktionen
    • 14. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 12. Juni 2000
    Geliefert am 20. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Business premium account no.40082090. The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security interest agreement
    Erstellt am 14. Apr. 2000
    Geliefert am 25. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the obligors and the parents to the finance parties (or any of them) under each of the finance documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    Without affecting and in addition to the agent's other rights under or pursuant to the security interest agreement,the company to the intent that the agent shall have a security interest in accordance with the law: assigned,transferred and otherwise made over to the agent title to the securities;and agreed that,to the extent that the company has not assigned,transferred or otherwise made over to the agent or perfected in favour of the agent,title to any securities the agent shall have possession of the certificates of title thereto.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Apr. 2000
    Geliefert am 20. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the obligors and the parents to the finance parties (or any of them) under each of the finance documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    The mortgaged property and all its present and future investments in any subsidiary of the company.assignment by way of security.fixed charges.floating charge.real property.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 20. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 1997
    Geliefert am 08. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any finance document (the "secured obligations")
    Kurze Angaben
    Freehold property known as 139 and 140 park lane and 535, 537 and 539 oxford street title number 420074 and leasehold property known as park lane garages, 68 north row, london W1. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bhf-Bank Ag(The "Agent")
    Transaktionen
    • 08. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0