DISCFIND LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DISCFIND LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03315136 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DISCFIND LIMITED?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich DISCFIND LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square E1W 1YW London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DISCFIND LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DISCFIND LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG04 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patrick Colvin als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patrick Colvin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Michael Robert Goldberger am 15. Dez. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Robert Goldberger am 15. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DISCFIND LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDBERGER, Michael Robert | Sekretär | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | British | 77295560002 | ||||||
| GOLDBERGER, Michael Robert | Geschäftsführer | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | United Kingdom | British | 77295560002 | |||||
| PEARLMAN, David Alan | Geschäftsführer | Sheldon Avenue Highgate N6 4JT London 26 | United Kingdom | British | 35550120001 | |||||
| COLVIN, Patrick | Sekretär | Great Oaks Hutton CM13 1AZ Brentwood 19 Essex | British | 5954030001 | ||||||
| CRICKMORE, Nicola Jane | Sekretär | Brelston Court Barn HR9 6HF Marstow Herefordshire | British | 115328860001 | ||||||
| HUGGINS, Brian John | Sekretär | 169 Timberlog Lane SS14 1PJ Basildon Essex | British | 63149960001 | ||||||
| NEEDHAM, Ivan Arthur | Sekretär | 45 Shearwater New Barn DA3 7NL Longfield Kent | British | 3471370001 | ||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| WALGATE SERVICES LIMITED | Sekretär | 25 North Row W1K 6DJ London | 59142480001 | |||||||
| CARLTON PORTER, Robert William | Geschäftsführer | 4 Laggan House College Road BA1 5RY Bath Avon | United Kingdom | British | 67566540006 | |||||
| COLVIN, Patrick | Geschäftsführer | Great Oaks Hutton CM13 1AZ Brentwood 19 Essex | England | British | 5954030001 | |||||
| CRICKMORE, Nicola Jane | Geschäftsführer | Brelston Court Barn HR9 6HF Marstow Herefordshire | United Kingdom | British | 115328860001 | |||||
| GADSDEN, Eric John Spencer | Geschäftsführer | Hawridge Place Hawridge HP5 2UG Chesham Buckinghamshire | England | British | 13515270003 | |||||
| JOHNSON, Simon Harcourt | Geschäftsführer | 14 Bathurst Mews W2 2SB London | British | 37681220001 | ||||||
| LANDAU, Ervin | Geschäftsführer | 78 Harley House Marylebone Road NW1 5HN London | United Kingdom | British | 91134410001 | |||||
| LEWIN, Peter Harry | Geschäftsführer | 1 Wolsey Road Moor Park HA6 2HN Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 2652710001 | |||||
| MULDOON, John Gerard | Geschäftsführer | 16 Carbery Avenue BH6 3LF Bournemouth Dorset | England | British | 94510780001 | |||||
| SZERKOWSKI, Joram | Geschäftsführer | 87 Campden Street W8 7EN London | German | 53915690001 | ||||||
| TOMLINSON, Brian | Geschäftsführer | 18 Picadilly Court Queens Promenade IM2 4NS Douglas Isle Of Man | British | 75490660002 | ||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Hat DISCFIND LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 07. Juli 2006 Geliefert am 25. Juli 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 65-73 (odd) the parade high street watford t/no HD184726, 1 marlborough place and 119 and 120 church street brighton t/no ESX194404, westbury court moulton park northampton t/no NN132570. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. März 2002 Geliefert am 08. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 65-73 (odd) the parade high street watford t/n HD184726, blenheim house being 1 marlborough place and 119-120 church street brighton and hove t/n ESX194404 and westbury court moulton park (2-3 moulton park) northampton t/n NN132570. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Mai 1999 Geliefert am 07. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property k/a stoke abbott court chapel road worthing west sussex t/n WSX22624, 1 marlbrough place and 119 church street brighton east sussex t/n ESX194404 for further properties please refer yo form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 19. März 1999 Geliefert am 06. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rights title benefit and interest to and in all sums of money held on time deposit ref 351924 and any substitue and replacement account please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 28. Feb. 1997 Geliefert am 03. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H properties at angel gate city road l/b of islington k/a units 17/18 & unit 24 t/no's ngl 717397 NGL717394 and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0