OAKGATE (HEREFORD) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOAKGATE (HEREFORD) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03315907
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OAKGATE (HEREFORD) LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich OAKGATE (HEREFORD) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    BDO LLP
    3 Hardman Street Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OAKGATE (HEREFORD) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    UNIQUEBREAK LIMITED10. Feb. 199710. Feb. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OAKGATE (HEREFORD) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für OAKGATE (HEREFORD) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für OAKGATE (HEREFORD) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 02. Dez. 2014

    6 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    2 Seiten4.72

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    5 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom North House 17 North John Street Liverpool Merseyside L2 5EA am 21. Jan. 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Ernennung von Mr William Crocker als Sekretär am 30. Juni 2013

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Andrew Robert Lovelady als Geschäftsführer am 30. Juni 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Robert Lovelady als Sekretär am 30. Juni 2013

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Feb. 2013

    Kapitalaufstellung am 12. Feb. 2013

    • Kapital: GBP 990,778
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    14 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    15 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Approve facilities agreement 22/03/2012
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    15 SeitenAA

    legacy

    14 SeitenMG01

    legacy

    33 SeitenMG01

    legacy

    22 SeitenMG01

    Ernennung von William Richard Crocker als Direktor

    3 SeitenAP01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2009 bis 31. März 2010

    3 SeitenAA01

    Wer sind die Geschäftsführer von OAKGATE (HEREFORD) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CROCKER, William
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    Sekretär
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    179448230001
    SILVANO, Helen
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    British55343270002
    CROCKER, William Richard
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    Geschäftsführer
    Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    3
    United KingdomBritish117141950001
    OWEN, Michael Barry
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    EnglandBritish69716360003
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Sekretär
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    British41693730006
    WILKINSON, Christopher John
    46 Grange Road
    Bowdon
    WA14 3EY Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    46 Grange Road
    Bowdon
    WA14 3EY Altrincham
    Cheshire
    British90439130001
    WILLIAMS, Stephen Robert
    15 Charlesbye Avenue
    L39 2XY Ormskirk
    Lancashire
    Sekretär
    15 Charlesbye Avenue
    L39 2XY Ormskirk
    Lancashire
    British911620001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUSTIN, Ronald George
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    Geschäftsführer
    Blythe House
    Sandfield Park
    L12 1NA Liverpool
    British36193370001
    FRANCE, Richard Edward
    Appleton House
    Main Street Appleton Roebuck
    YO23 7DG York
    Geschäftsführer
    Appleton House
    Main Street Appleton Roebuck
    YO23 7DG York
    United KingdomBritish56208840002
    GRANTHAM, John
    The Hollins Wescoe Hill Lane
    Weeton
    LS17 0AS Leeds
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Hollins Wescoe Hill Lane
    Weeton
    LS17 0AS Leeds
    North Yorkshire
    British48928850001
    HOSKINSON, Philip Edward
    Thorlands
    Mill Hill Road
    CH61 4XA Wirral
    Wirral
    Geschäftsführer
    Thorlands
    Mill Hill Road
    CH61 4XA Wirral
    Wirral
    British69384790001
    JONES, Pamela
    State House 22 Dale Street
    L2 4UR Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    State House 22 Dale Street
    L2 4UR Liverpool
    Merseyside
    British13200620001
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Geschäftsführer
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritish41693730006
    WILLIAMS, Stephen Robert
    15 Charlesbye Avenue
    L39 2XY Ormskirk
    Lancashire
    Geschäftsführer
    15 Charlesbye Avenue
    L39 2XY Ormskirk
    Lancashire
    British911620001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat OAKGATE (HEREFORD) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2010
    Geliefert am 14. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to any loan note holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of charged properties please refer to the form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Stephen George Laing as Lone Note Holder Security Trustee Pamela Jones as Loan Note Holder Security Trustee
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2010
    Geliefert am 08. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of property charged please refer to form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Upside fee debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2010
    Geliefert am 08. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminter Bank PLC (Upside Fee Security Trustee)
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 13. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 2, 4 and 6 eign gate hereford t/no HW157776 fixed charge all rents receivable from any lease granted out of the property and the proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trsutee)
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2006
    Geliefert am 11. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any receiver on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 2, 4 and 6 eign gate, hereford t/no HW157776 by way of fixed charge all rents receivable from any lease granted out of the property and the proceeds of any insurance from time to time affecting the property.
    Berechtigte Personen
    • National Westminister Bank PLC (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Jan. 1999
    Geliefert am 04. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement together with all other monies owing from time to time by the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land and buildings k/a 8 eign gate hereford. By way of assignment:- (I) the benefit of all contracts deeds undertakings agreements indemnities of any nature now or at any time enjoyed or held by the company and relating to the property and/or the development of the properties;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ethel Austin Investment Properties Limited
    Transaktionen
    • 04. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Jan. 1999
    Geliefert am 25. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 8 eign gate hereford herefordshire t/no: HW56627. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 1997
    Geliefert am 10. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility agreement dated 30TH october 1997
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings 2-6 eign gate hereford t/n HW157776 the benefit of all contracts deeds undertakings agreements right warranties securities covenants guarantees bonds and indemnities the benefit of all insurance policies and contracts of insurance rentals rents service charges and licence fees in respect of underleases tenancy or leases.
    Berechtigte Personen
    • Ethel Austin Investment Properties Limited
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Nov. 1997
    Geliefert am 16. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 2 to 6 eign gate,hereford hereford & worcester t/no.hw 157776 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat OAKGATE (HEREFORD) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Nov. 2013Beginn der Liquidation
    05. März 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian James Gould
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Jonathan David Newell
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0