SIGNS AND LABELS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SIGNS AND LABELS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03318384 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SIGNS AND LABELS LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich SIGNS AND LABELS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Douglas Bruce House Corrie Way SK6 2RR Bredbury Park Industrial Estate Bredbury Stockport |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SIGNS AND LABELS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SIGNS & LABELS GROUP LIMITED | 26. März 1998 | 26. März 1998 |
| MARPLACE (NUMBER 405) LIMITED | 14. Feb. 1997 | 14. Feb. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SIGNS AND LABELS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2006 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SIGNS AND LABELS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:sos cert release of liquidator | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Insolvenzmeldung INSOLVENCY:Form 4.40 g g Bates ceasing to act | 1 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order INSOLVENCY:Replacement of Liquidator p j Windatt Replaces gg Bates 15/12/2009 | 13 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Okt. 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. Apr. 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 9 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2006 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 88(2)R | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 88(2)R | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2005 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 244 | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 363s | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 04. Dez. 2004 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SIGNS AND LABELS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON, John Paul | Sekretär | 4 Knightwood Glade Chandlers Ford SO53 4JA Eastleigh Hampshire | British | 122350180001 | ||||||
| FELMER, Thomas James | Geschäftsführer | Hilly Lane Saukville 8821 Wisconsine United States | United States Of America | American | 128854080001 | |||||
| JAEHNERT, Frank Michael | Geschäftsführer | W68n1068 Kensington Avenue 53012 Cedarburg Wisconsin Usa | United States Of America | Usa | 68305240001 | |||||
| SEPHTON, Peter Charles | Geschäftsführer | The Coach House Severnstoke Bank WR8 9JG Severnstoke Worcestershire | United Kingdom | British | 59319040003 | |||||
| WALSHAM, Andrew Stuart | Geschäftsführer | 15 Elm Road SN7 7EJ Faringdon Oxfordshire | United Kingdom | British | 33682210002 | |||||
| BRANDWOOD, Christopher Mark | Sekretär | Oak House Oak Road Mottram St Andrew SK10 4RA Macclesfield Cheshire | British | 46508870001 | ||||||
| HIGHAM, Maria Gabrielle | Sekretär | Eastcote 25 Delahays Road WA15 8DS Hale Cheshire | British | 56630460001 | ||||||
| ASHLEY, Desmond Owen | Geschäftsführer | Holly Barn Holly Tree Walk Claybrooke Magna LE17 5DZ Lutterworth Leicestershire | England | United Kingdom | 53386540002 | |||||
| FITZGERALD, David Sean | Geschäftsführer | 1 Greenmount Gardens Greenmount BL8 4HN Bury Lancashire | British | 61196400001 | ||||||
| HIGHAM, Maria Gabrielle | Geschäftsführer | Eastcote 25 Delahays Road WA15 8DS Hale Cheshire | British | 56630460001 | ||||||
| HYAMS, Anthony Michael | Geschäftsführer | 8 Bonville Chase WA14 4QA Altrincham Cheshire | British | 56167340004 | ||||||
| MACDONALD, Iain Archibald | Geschäftsführer | 7 Hermitage Gardens EH10 6DL Edinburgh | Scotland | British | 3614100004 | |||||
| MATHIESON, David | Geschäftsführer | 10920 North Elizabeth Court Mequon Wisconsin 53097 Usa | British | 106586110001 | ||||||
| PADBERG, Mark Walter | Geschäftsführer | Thatchways Knobfield RH5 6RJ Abinger Hamer Surrey | British | 89261420001 | ||||||
| ROCHE, Susan Louise | Geschäftsführer | Rose Farm Astley Moss M29 7LX Manchester | Usa | 96243330001 | ||||||
| SCHOLES, Jeremy Hacking | Geschäftsführer | 11 Gleneagles Drive Brockhall Village BB6 8BF Old Langho Lancashire | England | British | 108377220001 | |||||
| STOREY, Richard George | Geschäftsführer | 49 Kennerley Road SK2 6EU Stockport Cheshire | British | 11628330002 |
Hat SIGNS AND LABELS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Erstellt am 08. Dez. 2003 Geliefert am 09. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as signs and labels group limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of life policy | Erstellt am 07. Okt. 2002 Erworben am 28. Nov. 2003 Geliefert am 22. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Policy number jlt 18433 dated 8 may 2002 for £250,000 over the life of maria gabrielle higham. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 10. Mai 2002 Erworben am 28. Nov. 2003 Geliefert am 22. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of life policy | Erstellt am 21. Okt. 1997 Erworben am 28. Nov. 2003 Geliefert am 22. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Policy number RNF000401 52A with sun alliance and london insurance company limited in the life of richard storey. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Juli 1997 Erworben am 26. Nov. 2003 Geliefert am 22. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Juli 1997 Geliefert am 16. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fittings fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SIGNS AND LABELS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0