PNANT REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePNANT REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03319495
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PNANT REALISATIONS LIMITED?

    • (9305) /

    Wo befindet sich PNANT REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PNANT REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PEACOCKS (NANTGARW) LIMITED07. Apr. 199707. Apr. 1997
    GUIDEUNIQUE LIMITED17. Feb. 199717. Feb. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PNANT REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis03. Apr. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PNANT REALISATIONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für PNANT REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    GAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Apr. 2014

    36 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    36 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Jan. 2014

    32 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Juli 2013

    34 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Juli 2013

    33 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Jan. 2013

    53 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 18. Juli 2012

    58 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    101 Seiten2.17B

    legacy

    4 SeitenMG04

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed peacocks (nantgarw) LIMITED\certificate issued on 29/02/12
    2 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name29. Feb. 2012

    Beschluss zur Änderung der Firma am 27. Feb. 2012

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Capital Link Windsor Road Cardiff CF24 5NG Wales* am 25. Jan. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Roy George Ellis als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Michael Killick als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Apr. 2011

    Kapitalaufstellung am 08. Apr. 2011

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 03. Apr. 2010

    18 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Atlantic House Tyndall Street Cardiff CF10 4PS* am 31. Aug. 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von PNANT REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ELLIS, Roy George
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    Sekretär
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    British116788900001
    BURNS, Neil Anthony
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    Geschäftsführer
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    WalesBritish62596180004
    ELLIS, Roy George
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    WalesBritish161784490001
    KIRK, Richard Stanley, Mr.
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    United KingdomBritish54276260003
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Sekretär
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    British75927820002
    WIGLEY, Islwyn Thomas
    21 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    Sekretär
    21 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    British49912180001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRYANT, Keith Ralph
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    Geschäftsführer
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    United KingdomBritish54831150003
    GIPSON, Stephen
    Rose Cottage
    Piccadilly
    CF71 7JL Llanblethin
    Vale Of Glamorgan
    Geschäftsführer
    Rose Cottage
    Piccadilly
    CF71 7JL Llanblethin
    Vale Of Glamorgan
    British90147660001
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Geschäftsführer
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    WalesBritish75927820002
    PEACOCK, Robert Frank
    Allt Laes Farm
    Cnepyn Lane Peterston Super Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Geschäftsführer
    Allt Laes Farm
    Cnepyn Lane Peterston Super Ely
    CF5 6NE Cardiff
    British13070020001
    WOODHOUSE, Anthony John
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    Geschäftsführer
    Groesfaen Road
    Peterston-Super-Ely
    CF5 6NE Cardiff
    Elm House
    United KingdomBritish131678400001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat PNANT REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2006
    Geliefert am 31. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the non-consent mortgaged property the additional property the tangible moveable property the accounts the intellectual property the charged intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares and all dividends. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P. as Security Trustees for and on Behalf of the Securedparties
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Juli 2002
    Geliefert am 25. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge all its right, title and interest in and to the property k/a 17 & 18 taff street, pontypridd t/no. WA545538 and unit e, cae mawr industrial estate t/no. WA957651 and any buildings fixtures fittings fixed plant or machinery thereon and all related rights (the real property) and the intellectual property. First floating charge the whole of its undertaking and assets, present and future, other than any assets validly and effectively charged by way of fixed charge.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC, as Security Trustee
    Transaktionen
    • 25. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A debenture made by the company,the peacock group PLC,dorsman estates co.limited and peacock's stores limited (together with the company,the "chargors")
    Erstellt am 12. Sept. 2001
    Geliefert am 18. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations due or to become due from the chargor to the chargee,as trustee for the secured parties (as defined) under or pursuant to the secured documents (as defined), including the debenture, and including any liability in respect of any further advances made under the secured documents
    Kurze Angaben
    First fixed charge over all rights,title and interest from time to time in and to the real property known as (I) 17 and 18 taff street,pontypridd,rhondda cyon taff (wa 545538) and (ii) unit e,cae mawr industrial estate,treorchy,rhondda cyon taff (wa 957651) with all buildings,fixtures,fittings,fixed plant or machinery thereon; see form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture between the company, the chargors (as defined) and the governor and company of the bank of scotland (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined)
    Erstellt am 02. Dez. 1999
    Geliefert am 17. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders (As Defined)
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Sept. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Apr. 1997
    Geliefert am 14. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as guideunique limited to the chargee under a funding agreement on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a unit 4 business parc cynon taf rhondda t/n wa 579800. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coverkit Limited
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PNANT REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Jan. 2012Beginn der Verwaltung
    30. Apr. 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Christine Mary Laverty
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Edward George Boyle
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jonathan Scott Pope
    Marlborough House Fitzalan Court
    Fitzalan Road
    CF24 0TE Cardiff
    Praktiker
    Marlborough House Fitzalan Court
    Fitzalan Road
    CF24 0TE Cardiff

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0