ADAMSON DEVELOPMENTS (NEWCASTLE) LIMITED

ADAMSON DEVELOPMENTS (NEWCASTLE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameADAMSON DEVELOPMENTS (NEWCASTLE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03319984
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ADAMSON DEVELOPMENTS (NEWCASTLE) LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich ADAMSON DEVELOPMENTS (NEWCASTLE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    45 Castledene Court
    South Gosforth
    NE3 1NZ Newcastle Upon Tyne
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ADAMSON DEVELOPMENTS (NEWCASTLE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CROSSCO (244) LIMITED18. Feb. 199718. Feb. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ADAMSON DEVELOPMENTS (NEWCASTLE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für ADAMSON DEVELOPMENTS (NEWCASTLE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 13. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    6 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008

    9 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    6 Seiten363s

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2006

    8 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    Seiten363(288)

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2005

    7 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2004

    8 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten395

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2003

    7 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ADAMSON DEVELOPMENTS (NEWCASTLE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PRIME, Jonathan Mark
    Castledene Court
    NE3 1NZ Newcastle Upon Tyne
    45
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Castledene Court
    NE3 1NZ Newcastle Upon Tyne
    45
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish63515050002
    ADAMSON, John Richard
    Sweet Hope
    Old Mousen
    NE70 7HN Belford
    Northumberland
    Sekretär
    Sweet Hope
    Old Mousen
    NE70 7HN Belford
    Northumberland
    British32017540008
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    West House Whorlton Hall Farm
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British41507630001
    MIDDLETON, Kay Wendy
    19 Alma Place
    NE29 0NQ North Shields
    Tyne & Wear
    Sekretär
    19 Alma Place
    NE29 0NQ North Shields
    Tyne & Wear
    British10319200001
    MIDDLETON, Kay Wendy
    19 Alma Place
    NE29 0NQ North Shields
    Tyne & Wear
    Sekretär
    19 Alma Place
    NE29 0NQ North Shields
    Tyne & Wear
    British10319200001
    SMITH, Ian Morgan
    59 Shotley Gardens
    Low Fell
    NE9 5DP Gateshead
    Tyne & Wear
    Sekretär
    59 Shotley Gardens
    Low Fell
    NE9 5DP Gateshead
    Tyne & Wear
    British122250280001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Sekretär
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    DICKINSON DEES
    Cross House
    Westgate Road
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Bevollmächtigter Sekretär
    Cross House
    Westgate Road
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    900005460001
    ADAMSON, John Richard
    Sweet Hope
    Old Mousen
    NE70 7HN Belford
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Sweet Hope
    Old Mousen
    NE70 7HN Belford
    Northumberland
    EnglandBritish32017540008
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    West House Whorlton Hall Farm
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British41507630001

    Hat ADAMSON DEVELOPMENTS (NEWCASTLE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juni 2004
    Geliefert am 18. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £375,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property k/a 40 hanover street newcastle upon tyne t/n:TY175086 and all rights and benefits accruing to or arising in connection therewith.
    Berechtigte Personen
    • Tolent Construction Limited
    Transaktionen
    • 18. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 05. Sept. 2001
    Geliefert am 11. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The principal sum and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all that f/h property k/a flat 1, foresetr court, durham road, loww fell, newcastle upon tyne, NE9 1BT and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Northern Rock PLC
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Share pledge
    Erstellt am 20. Juli 2001
    Geliefert am 25. Juli 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or morrison homes limited and/or morrison construction limited and/or awg developments limited under and in terms of the contracts and the shareholders agreements and the mri security (all as defined therein)
    Kurze Angaben
    The one b ordinary share of £1 in adamson developments including any dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morrison Residential Investments Limited
    Transaktionen
    • 25. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Share pledge
    Erstellt am 05. Nov. 1999
    Geliefert am 11. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in terms of the contracts and the shareholders agreement (as therein defined) as all or any of the same may be amended varied or replace from time to time
    Kurze Angaben
    1 b ordinary share of £1 in adamson developments (gosforth) limited and all rights and property accruing therefrom and any dividends paid. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morrison Residential Investments Limited
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 26. Okt. 1999
    Geliefert am 10. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Share pledge
    Erstellt am 25. März 1999
    Geliefert am 13. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the development agreement and the shareholders agreement of even date
    Kurze Angaben
    The 1 a ordinary share of £1 in adamson decelopments (low fell) limited ("the security share") and all rights and property accruing in respect of the security share (including any dividends paid and received).
    Berechtigte Personen
    • Morrison Residential Investments Limited
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Apr. 1997
    Geliefert am 29. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the f/h land and buildings on the north side of hutton terrace jesmond newcastle comprised (in part) t/n-ty 292357. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Apr. 1997
    Geliefert am 29. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-hutton terrace jesmond newcastle upon tyne being comprised (in part) t/n-TY29235. By way of legal mortgage all other f/h and l/h property; by way of specific equitable charge all future f/h and l/h property; by way of specific charge all stocks shares and/or other securities; by way of specific charge all book and other debts, all fixed plant and machinery; by way of floating charge its undertaking and assets and rights, other than those charged above, whatsoever and wheresoever present in the future. By way of assignment its goodwill.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Apr. 1997
    Geliefert am 25. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land at hutton terrace t/no TY292357 with all buildings & other constructions and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cala Finance Limited
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0