SALMAN INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSALMAN INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03322073
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SALMAN INVESTMENTS LIMITED?

    • (7020) /

    Wo befindet sich SALMAN INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hunter House 109, Snakes Lane
    West, Woodford Green
    IG8 0DY Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SALMAN INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FAL INVESTMENTS LIMITED21. Feb. 199721. Feb. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SALMAN INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Nov. 2006

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SALMAN INVESTMENTS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SALMAN INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 20. Nov. 2013

    2 Seiten3.6

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 21. Sept. 2013

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 21. März 2013

    2 Seiten3.6

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 21. Sept. 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 21. März 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 21. Sept. 2011

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 21. März 2011

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 21. Sept. 2010

    2 Seiten3.6

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    legacy

    1 SeitenLQ01

    legacy

    1 SeitenLQ01

    legacy

    1 SeitenLQ01

    legacy

    1 SeitenLQ01

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von SALMAN INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHEIKH, Raana Gauhar Noman
    5 Clarewood Court
    Seymour Place
    W1H 2NL London
    Sekretär
    5 Clarewood Court
    Seymour Place
    W1H 2NL London
    Other14808270004
    SHEIKH, Mohammad Noman, Dr
    5 Clarewood Court
    Seymour Place
    W1H 2NL London
    Geschäftsführer
    5 Clarewood Court
    Seymour Place
    W1H 2NL London
    British14808260004
    ABU BAKR, Mohammed
    48 Spencer Road
    TW7 4BH Isleworth
    Middlesex
    Sekretär
    48 Spencer Road
    TW7 4BH Isleworth
    Middlesex
    Indian51865900002
    ENERGIZE SECRETARY LIMITED
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    900012910001
    AL-FARSI, Salman
    6 Widmer Court
    Vicarage Farm Road
    TW3 4NL Hounslow
    Middlesex
    Geschäftsführer
    6 Widmer Court
    Vicarage Farm Road
    TW3 4NL Hounslow
    Middlesex
    British65616820001
    ENERGIZE DIRECTOR LIMITED
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    900014010001

    Hat SALMAN INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 22. März 2007
    Geliefert am 30. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    76 grove hall court hall road london,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 26. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 221. Nov. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 2
    Legal charge
    Erstellt am 22. März 2007
    Geliefert am 30. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 27 jenner house hunter street london,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 26. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 521. Nov. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 5
    Legal charge
    Erstellt am 22. März 2007
    Geliefert am 30. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    48 paramount court university street london,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 26. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 321. Nov. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 3
    Legal charge
    Erstellt am 22. März 2007
    Geliefert am 30. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 22 rossmore court park road london,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 26. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 26. Sept. 2009Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 421. Nov. 2013Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 4
    Debenture
    Erstellt am 20. März 2007
    Geliefert am 22. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Nov. 2005
    Geliefert am 18. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 48 paramount court university street london.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Nov. 2005
    Geliefert am 18. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 76 grove hall court hall road london.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Nov. 2005
    Geliefert am 18. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 27 jenner house hunter street london.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Nov. 2005
    Geliefert am 18. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 22 rossmore court park road london.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. März 2003
    Geliefert am 20. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 20. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. März 2003
    Geliefert am 20. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the l/h property k/a 27 jenner house hunter street st pancras london borough of camden t/no NGL743418,48 paramount court university street WC1E 6JP london borough of camden t/no NGL451710,22 rossmore court park road city of westminster t/no NGL183840 for further details of property charged please see schedule to form 395. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 20. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Corporate guarantee
    Erstellt am 27. Juni 2001
    Geliefert am 06. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The company unconditionally guarantees the payment or discharge of the security credit and banking facilities granted to orchard house properties limited rns estates limited and rns holdings limited.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Erstellt am 27. Juni 2001
    Geliefert am 06. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party legal charge
    Erstellt am 08. Jan. 1999
    Geliefert am 21. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property known as 9 cleveland court,cleveland st,london W.1; t/no NGL287835. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Sept. 1998
    Geliefert am 01. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 48 paramount court london t/n NGL451710. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Feb. 1998
    Geliefert am 18. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    76 grove hall court hall road st johns wood london. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Nov. 1997
    Geliefert am 04. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 22 rossmore court park road london NW1 t/n NGL183840. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 1997
    Geliefert am 14. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage,l/h property k/a 27 jenner house hunter street st pancras (t/no.ngl 743418.. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SALMAN INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Joseph Antony Pitt
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Receiver Manager
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Benedict James Nicholas Moon
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Receiver Manager
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Joseph Antony Pitt
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Receiver Manager
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Benedict James Nicholas Moon
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Receiver Manager
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    4Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Joseph Antony Pitt
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Receiver Manager
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Benedict James Nicholas Moon
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Receiver Manager
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    5Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Joseph Antony Pitt
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Receiver Manager
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Benedict James Nicholas Moon
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    Receiver Manager
    90 Chancery Lane
    WC2A 1EU London
    6
    DatumTyp
    05. März 2014Abschluss der Liquidation
    02. März 2012Antragsdatum
    30. Apr. 2012Beginn der Liquidation
    07. Juni 2014Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0