ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03324967 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bridgeway House Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Warwickshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MORETHANHOTELS (STAFFORD) LIMITED | 25. Nov. 2005 | 25. Nov. 2005 |
| FOREMOST HOTELS (STAFFORD) LIMITED | 30. Mai 2003 | 30. Mai 2003 |
| INGRAM (STAFFORD) LIMITED | 09. Juli 1998 | 09. Juli 1998 |
| ROADCHEF (STAFFORD) LIMITED | 23. Apr. 1997 | 23. Apr. 1997 |
| BEALAW (430) LIMITED | 27. Feb. 1997 | 27. Feb. 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Cessation of Atlas Hotels (Group 4 Property 2) Limited as a person with significant control on 12. Dez. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of London and Regional Group Hotel Holdings Ltd as a person with significant control on 12. Dez. 2019 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Adrian Paul Bradley als Direktor am 19. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Ian Griffiths als Geschäftsführer am 05. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sean Joseph Lowe als Direktor am 05. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 033249670006 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom No.1 London Bridge London SE1 9BG England zum Quadrant House, Floor 6 4 Thomas More Square London E1W 1YW geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2016 bis 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 033249670005 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 18 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 033249670006, erstellt am 21. Juni 2016 | 89 Seiten | MR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 17 Dominion Street London EC2M 2EF zum Bridgeway House Bridgeway Stratford-upon-Avon Warwickshire CV37 6YX am 29. Juni 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Shaun Robinson als Geschäftsführer am 21. Juni 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADLEY, Adrian Paul | Geschäftsführer | Baker Street W1U 8EW London 55 United Kingdom | United Kingdom | British | 90379240002 | |||||
| LOWE, Sean Joseph | Geschäftsführer | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 195752560001 | |||||
| INGRAM HILL, Sarah | Sekretär | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 59327230001 | ||||||
| MCCOLL, Fraser Robert | Sekretär | Broom Cottage 1 Lodge Lane TN16 1RH Westerham Kent | British | 70649620002 | ||||||
| PENDRILL, Richard William | Sekretär | Boscobel Sweetwater Lane Wormley GU8 5SS Godalming Surrey | British | 5919770001 | ||||||
| WARWICK, Timothy James | Sekretär | Plas Y Coed 3 Cwrt Y Cadno St Fagans CF5 4PJ Cardiff Wales | British | 65745040001 | ||||||
| BEACH SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 900002710001 | |||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||
| BARNES, Robert Digby Phillips | Geschäftsführer | Brampton Chase Summerhouse Road GU7 1PY Godalming Surrey | United Kingdom | British | 59539070002 | |||||
| BELL, Alastair Marshall | Geschäftsführer | 8 Thackeray Close Wimbledon SW19 4JL London | England | British | 87778630001 | |||||
| COUTURIER, Philippe | Geschäftsführer | Dominion Street EC2M 2EF London 17 United Kingdom | England | French | 185748330001 | |||||
| DARLING, Mervyn | Geschäftsführer | St James's House Charlotte Street M1 4DZ Manchester Allied Irish Bank United Kingdom | United Kingdom | Irish | 147824160001 | |||||
| DE BURETEL DE CHASSEY, Marc Frederic Marie | Geschäftsführer | 19 Furlong Road N7 8LS London | French | 110966050002 | ||||||
| DESSOKY, Usama | Geschäftsführer | 5 Rudgwick Terrace 20 Avenue Road NW8 6BR London | England | British | 85181940001 | |||||
| DODD, Angus Alexander | Geschäftsführer | 13 Redgrave Road SW15 1PX London | British | 110965490001 | ||||||
| DUNN, Barrie | Geschäftsführer | B316 Peninsula Apartments 4 Praed Street W2 1JE London | United Kingdom | British | 109512300001 | |||||
| EDDIS, Christopher Frederick | Geschäftsführer | 102 Portland Road Holland Park W11 4LX London | United Kingdom | British | 59311260003 | |||||
| GILLESPIE, Brendan | Geschäftsführer | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office United Kingdom | British | 129902710001 | ||||||
| GRAUERS, Clifford Eric | Geschäftsführer | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office United Kingdom | England | British | 60557140001 | |||||
| GRAY, Robert Edward | Geschäftsführer | Dominion Street EC2M 2EF London 17 | United Kingdom | British | 188584900001 | |||||
| GRIFFITHS, Keith Ian | Geschäftsführer | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 77782610002 | |||||
| HILL, Timothy Ingram | Geschäftsführer | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 57283990001 | ||||||
| HORTHY, Sharif Istvan | Geschäftsführer | 43 St Annes Crescent BN7 1SD Lewes East Sussex | England | British | 59598440001 | |||||
| INGRAM HILL, Sarah | Geschäftsführer | Monks Hollow Alton Priors SN8 4JX Marlborough Wiltshire | British | 59327230001 | ||||||
| KINGSMILL, Robert Martin | Geschäftsführer | Express By Holiday Inn Birmingham Nec Bickenhill Parkway B40 1QA Birmingham Central Office | United Kingdom | British | 139337530001 | |||||
| MCKEVITT, Richard | Geschäftsführer | Nightingales Lane HP8 4SF Chalfont St. Giles Tyhurst Buckinghamshire | United Kingdom | British | 142295770001 | |||||
| MERCHANT, David John | Geschäftsführer | 9 Fairmile Court KT11 2DS Cobham Surrey | England | British | 102844250001 | |||||
| MITCHELL, Stephen David | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5LS London 179 | England | British | 95336510001 | |||||
| MORAR, Neal | Geschäftsführer | Dominion Street EC2M 2EF London 17 United Kingdom | England | British | 173110500001 | |||||
| MYERS, David Paul | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5LS London 179 England | England | British | 142171370001 | |||||
| NOBLE, David | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5LS London 179-185 | England | British | 127359410001 | |||||
| ROBINSON, Shaun | Geschäftsführer | Bridgeway CV37 6YX Stratford-Upon-Avon Bridgeway House Warwickshire England | United Kingdom | British | 101627760001 | |||||
| STOCKTON, Richard | Geschäftsführer | Dominion Street EC2M 2EF London 17 | United Kingdom | British | 173676030001 | |||||
| WHITBY, Peter James | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5LS London 179-185 | England | English | 76096790002 | |||||
| CROFT NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 900002700001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London And Regional Group Hotel Holdings Ltd | 12. Dez. 2019 | 4 Thomas More Square E1W 1YW London Quadrant House, Floor 6 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Atlas Hotels (Group 4 Property 2) Limited | 06. Apr. 2016 | Dominion Street EC2M 2EF London 17 England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ATLAS HOTELS (STAFFORD NT 1) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 21. Juni 2016 Geliefert am 30. Juni 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The freehold and leasehold interests in holiday inn express stafford, stafford south, acton court, acton gate, stafford, ST18 9AP with title numbers SF384424 and SF381471 and SF525024 and, where the context so requires, includes the buildings on the property. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 17. Dez. 2014 Geliefert am 19. Dez. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Okt. 2007 Geliefert am 19. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The properties listed in schedule 2 of T. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Nov. 2005 Geliefert am 05. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land lying on the west side of redbridge lane mursling southampton t/no HP581790,land lying to the north of hyde road gorton manchester t/no GM821643,land at harbledown canterbury t/no K787140 (for details of further properties charged plea. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Mai 2003 Geliefert am 13. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from ingram hotels limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that l/h property k/a express by holiday inn stafford south acton court acton gate stafford t/n SF381471 together with the f/h land lying to the west of stafford road acton gate t/n SF384424. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Mai 2003 Geliefert am 13. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0