GWK AMTEK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGWK AMTEK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03326288
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GWK AMTEK LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich GWK AMTEK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite 306 Third Floor Fort Dunlop
    Fort Parkway
    B24 9FD Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GWK AMTEK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GWK GROUP LIMITED01. Mai 199701. Mai 1997
    FORAY 1011 LIMITED28. Feb. 199728. Feb. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GWK AMTEK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für GWK AMTEK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA
    R1MQA9EH

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA
    R1MQA9C2

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72
    AN6VKQRZ

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Nov. 2010

    5 Seiten4.68
    A7UEZPLY

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20
    A0V63FJC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600
    A0V65FJE

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Nov. 2009

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom King Automotive Systems Limited Chelmarsh Diamler Green Coventry CV6 3LT am 11. Nov. 2009

    2 SeitenAD01
    PXDM6EV0

    Änderung der Details des Direktors für John Ernest Flintham am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01
    XI4YHDU5

    Änderung der Details des Sekretärs für Phillipa Lucy Bishop am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03
    XHPALDU5

    Änderung der Details des Direktors für Arvind Dham am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01
    XHPB6DUR

    legacy

    1 Seiten288b
    XFEETA18

    legacy

    4 Seiten363a
    X8E1999B

    legacy

    18 Seiten395
    L7R5S8SG

    legacy

    1 Seiten403a
    AD8PP8HY

    legacy

    1 Seiten403a
    AD8PX8H6

    legacy

    1 Seiten403a
    AD8PV8H4

    legacy

    1 Seiten403a
    AD8PW8H5

    legacy

    1 Seiten403a
    AD8PT8H2

    legacy

    1 Seiten403a
    AD8PS8H1

    legacy

    1 Seiten403a
    AD8PU8H3

    legacy

    1 Seiten403a
    AD8PQ8HZ

    legacy

    1 Seiten288b
    X7FFT53Z

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    15 SeitenAA
    ACAY2512

    Wer sind die Geschäftsführer von GWK AMTEK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BISHOP, Phillipa Lucy
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    Sekretär
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    BritishCompany Secretary101086280001
    DHAM, Arvind
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    Geschäftsführer
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    IndiaIndianDirector93665890001
    FLINTHAM, John Ernest
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    Geschäftsführer
    King Automotive Systems Limited
    Chelmarsh
    CV6 3LT Diamler Green
    Coventry
    United KingdomBritishDirector36461330002
    DAVIDSON, Alan Neil Ramsay, Captain
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    Sekretär
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    BritishChairman63313000002
    DRURY, Richard Anthony
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    Sekretär
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    BritishFinance Director15235520001
    HYLAND, Matthew William Edward
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor43019310004
    PAUL, Peter Michael
    Keys Cottage
    School Lane Warmington
    OX17 1DE Banbury
    Oxon
    Sekretär
    Keys Cottage
    School Lane Warmington
    OX17 1DE Banbury
    Oxon
    British7677600001
    BENTON, Derek John
    Bridge House Bradnocks Marsh Lane
    Hampton In Arden
    B92 0LL Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Bridge House Bradnocks Marsh Lane
    Hampton In Arden
    B92 0LL Solihull
    West Midlands
    EnglandEnglishFinance Director38163810002
    CHURCHMAN, Richard Alan
    The Garden Flat
    43 Abbey Road St Johns Wood
    NW8 0AA London
    Geschäftsführer
    The Garden Flat
    43 Abbey Road St Johns Wood
    NW8 0AA London
    EnglandBritishDirector37813980001
    DAVIDSON, Alan Neil Ramsay, Captain
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    Geschäftsführer
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    United KingdomBritishChairman63313000002
    DRURY, Richard Anthony
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    BritishFinance Director15235520001
    FISHER, Jacqueline
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    BritishSecretary44103090001
    HYLAND, Matthew William Edward
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    29 Highbrow
    Harborne
    B17 9EW Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor43019310004
    PARKER, Kenneth
    The Holt 5 Kingfisher Way
    Sheepy Parva
    CV9 3SW Atherstone
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Holt 5 Kingfisher Way
    Sheepy Parva
    CV9 3SW Atherstone
    Leicestershire
    EnglandBritishCompany Director83139010002
    PAUL, Peter Michael, Director
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    BritishDirector7677600002
    SMITH, Philip Anthony
    7 Graeme Road
    Sutton
    PE5 7XE Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    7 Graeme Road
    Sutton
    PE5 7XE Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director117160910001
    SYAL, Ashwini Kumar
    Block A 90 Grd Floor
    South City
    Gurgaon
    Haryana 122001
    India
    Geschäftsführer
    Block A 90 Grd Floor
    South City
    Gurgaon
    Haryana 122001
    India
    IndianSales Manager98849180001
    WELCH, Roderick Brett
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director90527220001
    WINTERBOTTOM, David Stuart
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Walnuts End
    6 The Paddock Whitegate
    WA16 0GZ Northwich
    Cheshire
    BritishChairman6529580001

    Hat GWK AMTEK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 06. Apr. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ford Motor Company Limited
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 17. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 01. Nov. 2004
    Geliefert am 02. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policy: name of insurer: scottish equitable PLC policy number: LO197882942 name of life assured: alan neil ramsay davidson and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 01. Nov. 2004
    Geliefert am 02. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policy: name of insurer: scottish equitable PLC policy number: LO198092942 name of life assured: richard churchman and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of life policy
    Erstellt am 01. Nov. 2004
    Geliefert am 02. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The policy: name of insurer: scottish equitable PLC policy number: LO193682942 name of life assured: ken parker and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 24. Okt. 2003
    Geliefert am 07. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 24. Okt. 2003
    Geliefert am 29. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 12. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited (The Security Holder)
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all land now owned by the company including (without limitation) the properties being 25 year l/h interest in land and buildings on the north-west side of blackhorse road letchworth SG8 1EL t/n HD405547 and 25 year l/h interest in land and buildings lying to the east of capmartin road radford coventry CV6 3FX t/n WM763836. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all land now owned by the company including (without limitation) the properties being 25 year l/h interest in land and buildings on the north-west side of blackhorse road letchworth SG8 1EL t/n HD405547 and 25 year l/h interest in land and buildings lying to the east of capmartin road radford coventry CV6 3FX t/n WM763836. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Mai 1997
    Geliefert am 14. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as foray 1011 limited) to the chargee under the facilities agreement and the debenture as defined therein
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Mai 1997
    Geliefert am 14. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as foray 1011 limited) to the chargee under the facilities agreement and the debenture as defined therein
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Mai 1997
    Geliefert am 07. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as foray 1011 limited) to the chargee in respect of the loan (as defined)
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC, for Itself and as Trustee for the Investors (As Defined)
    Transaktionen
    • 07. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GWK AMTEK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Apr. 2011Aufgelöst am
    26. Nov. 2009Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Martin Frederick Peter Smith
    Suite 306 Third Floor
    Fort Dunlop
    B24 9FD Fort Parkway
    Birmingham
    Praktiker
    Suite 306 Third Floor
    Fort Dunlop
    B24 9FD Fort Parkway
    Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0