DIDGICOM LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDIDGICOM LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03326313
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DIDGICOM LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich DIDGICOM LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für DIDGICOM LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    6 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Dez. 2010

    Kapitalaufstellung am 09. Dez. 2010

    • Kapital: GBP 2.22
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Richard John Amos am 21. Nov. 2010

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Richard John Amos am 21. Nov. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2010

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von John Sadler als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Ernennung von Richard John Amos als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher John Humphrey am 01. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Neil Anthony Bass am 01. Dez. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr John Michael Sadler am 01. Dez. 2009

    1 SeitenCH03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Ernennung von Richard John Amos als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2009

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von DIDGICOM LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AMOS, Richard John
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Sekretär
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    British149450890001
    AMOS, Richard John
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Geschäftsführer
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    EnglandBritishCompany Director67950460002
    BASS, Neil Anthony
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Geschäftsführer
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    EnglandBritishDirector70199330002
    HUMPHREY, Christopher John
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Geschäftsführer
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    United KingdomBritishAccountant32877720003
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Sekretär
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Sekretär
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    HEMMIG, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxfordshire
    Sekretär
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxfordshire
    British77284520001
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Sekretär
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    OWEN, Janice Louise
    40 Moray Road
    N4 3LG London
    Sekretär
    40 Moray Road
    N4 3LG London
    BritishSolicitor71797370002
    PELEKANOS, Anna Louise
    11 Alverstone Road
    NW2 5JS London
    Sekretär
    11 Alverstone Road
    NW2 5JS London
    British102819560001
    SADLER, John Michael
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    Sekretär
    353 Buckingham Avenue
    Slough
    SL1 4PF Berkshire
    British78431540001
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Bevollmächtigter Sekretär
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004700001
    HAWKINS, John Eric
    Craven House
    Hamstead Marshall
    RG20 0JG Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Craven House
    Hamstead Marshall
    RG20 0JG Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishChief Executive53688120001
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Geschäftsführer
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    BritishCompany Director118771650001
    MOULDING, Arthur George
    46 Northolme Road
    N5 2UX Highbury
    Geschäftsführer
    46 Northolme Road
    N5 2UX Highbury
    BritishCompany Director98865270001
    MOULDING, Arthur George
    40 Moray Road
    N4 3LG London
    Geschäftsführer
    40 Moray Road
    N4 3LG London
    BritishDirector51826530002
    NIXON, Paul Stuart
    53a Shaftesbury Road
    N19 4QW London
    Geschäftsführer
    53a Shaftesbury Road
    N19 4QW London
    BritishCompany Director72180750001
    NIXON, Paul Stuart
    53a Shaftesbury Road
    N19 4QW London
    Geschäftsführer
    53a Shaftesbury Road
    N19 4QW London
    BritishDirector72180750001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director93738770001
    THORPE, David Allan
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector77702540001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director77284710002
    BRIGHTON DIRECTOR LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004690001

    Hat DIDGICOM LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28TH november 2006
    Erstellt am 04. März 2011
    Geliefert am 11. März 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Erstellt am 16. Feb. 2007
    Geliefert am 01. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Erstellt am 15. Feb. 2007
    Geliefert am 01. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 28. Nov. 2006
    Geliefert am 30. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    Erstellt am 28. Feb. 2006
    Geliefert am 02. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An omnibus letter of set-off
    Erstellt am 09. Dez. 2002
    Geliefert am 13. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 29. Nov. 1999
    Geliefert am 20. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0