EQUITY GROUP 2005 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEQUITY GROUP 2005 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03328307
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EQUITY GROUP 2005 LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich EQUITY GROUP 2005 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EQUITY GROUP 2005 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COX GROUP LIMITED28. Mai 199728. Mai 1997
    LOCHAID LIMITED05. März 199705. März 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EQUITY GROUP 2005 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für EQUITY GROUP 2005 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. März 2013

    4 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    4 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Library House, New Road Brentwood Essex CM14 4GD am 02. Apr. 2012

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 20. März 2012

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Mai 2011

    Kapitalaufstellung am 17. Mai 2011

    • Kapital: GBP 502
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2010

    10 SeitenAA

    Ernennung von David Andrew Turner als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Deryck Brown als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009

    11 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Victoria Louise Cuggy am 02. Okt. 2009

    3 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Victoria Louise Cuggy am 02. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Deryck Justin Brown am 02. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    16 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von EQUITY GROUP 2005 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CUGGY, Victoria Louise
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    Sekretär
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    British105782010002
    CUGGY, Victoria Louise
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    Geschäftsführer
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    United KingdomBritishCompany Secretary105782010002
    TURNER, David Andrew
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    Geschäftsführer
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    EnglandBritishSenior Accountant116524040001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    Sekretär
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    BritishCompany Secretary85213650001
    RINGROSE, Christopher James
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    Sekretär
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    British46372950001
    EXCELLET INVESTMENTS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Sekretär
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    1872620003
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BROWN, Deryck Justin
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    Geschäftsführer
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    United KingdomBritishAccountant123356160001
    CHARLES, Colin David
    The Holt 48 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Holt 48 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant46667150002
    COLTHURST, Henry Nicholas Almroth
    Asserton House
    Berwick St James
    SP3 4TZ Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Asserton House
    Berwick St James
    SP3 4TZ Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector168690530001
    CUGGY, Victoria Louise
    1 Canon Road
    Little Dunmow
    CM6 3GF Dunmow
    Essex
    Geschäftsführer
    1 Canon Road
    Little Dunmow
    CM6 3GF Dunmow
    Essex
    BritishCompany Secretary105782010001
    ELSTON, Andrew Henry
    Heatleys Cottage
    Middle Road
    CM13 3QW Ingrave
    Essex
    Geschäftsführer
    Heatleys Cottage
    Middle Road
    CM13 3QW Ingrave
    Essex
    BritishChartered Acountant98994410001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    Geschäftsführer
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    BritishCompany Secretary85213650001
    RINGROSE, Christopher James
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishChartered Accountant46372950001
    TURNER, David Andrew
    8 Bradley Close
    SS7 3AQ Benfleet
    Essex
    Geschäftsführer
    8 Bradley Close
    SS7 3AQ Benfleet
    Essex
    EnglandBritishSenior Accountant116524040001
    VINCENT, Paul John
    Field House
    Hockering Road
    GU22 7HJ Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Field House
    Hockering Road
    GU22 7HJ Woking
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant82872630001
    WARDLE, David Charles
    63 Ashingdon Heights
    SS4 3TH Rochford
    Essex
    Geschäftsführer
    63 Ashingdon Heights
    SS4 3TH Rochford
    Essex
    United KingdomBritishAccountant108018670001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    QUICKNESS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Geschäftsführer
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    47109420002

    Hat EQUITY GROUP 2005 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 13. Okt. 2004
    Geliefert am 27. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the trustee for the secured parties or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charges over the undertaking over the real property, the accounts, the insurance policies, the proceeds thereof and all related rights, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital, the investments, the shares, all dividends, interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights, all monetary claims; and each of the specific contracts, floating charge subject to the security under the original debenture;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of accession relating to a subordination and security trust deed dated 25 april 2002 and
    Erstellt am 20. Okt. 2003
    Geliefert am 03. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company has covenanted and agreed that in the event of payment or discharge (whether in cash by way of transfer of shares or other assets set-off or counterclaim or otherwise) being made to or an encumbrance being held by the company in breach of clause 3.2. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties Under the Subordination and Security Trust Deed
    Transaktionen
    • 03. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Okt. 2003
    Geliefert am 03. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the accounts, insurance policies, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital, the shares, all dividends, by way of first floating charge the whole of the companys undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC as Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 03. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EQUITY GROUP 2005 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Juli 2013Aufgelöst am
    20. März 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0