COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03334433 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?
- (7032) /
- (7222) /
- (7230) /
- (7514) /
Wo befindet sich COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DSSD FM LIMITED | 22. Apr. 1997 | 22. Apr. 1997 |
| NEARCO LIMITED | 12. März 1997 | 12. März 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Webster als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sherard Secretariat Services Limited am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building Oxfordshire United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| DUGGAN, Gillian | Geschäftsführer | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building Oxfordshire | England | British | 135453240001 | |||||||||
| EWELL, Melvyn | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 61515760002 | |||||||||
| NELSON, Andrew Latham | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 36191090003 | |||||||||
| GATEHOUSE, Howard Raymond | Sekretär | 19 Heathside Place KT18 5TX Epsom Downs Surrey | British | 59684220002 | ||||||||||
| HUI, Carol | Sekretär | Old Barn Petworth Road Witley GU8 5QW Godalming Surrey | British | 72371980001 | ||||||||||
| MANTZ, Ann Elizabeth | Sekretär | 21 Four Wents KT11 2NE Cobham Surrey | British | 37441550001 | ||||||||||
| MICHIE, Serena Mary Ann | Sekretär | 29b Thurloe Square SW7 2SD London | British | 51820880001 | ||||||||||
| RIDDLE, Gordon Henry | Sekretär | 22 The Hurdles Titchfield PO14 4AN Fareham Hampshire | British | 55039990003 | ||||||||||
| TETLOW, John Richard | Sekretär | Whittaker Court, Gawsworth New Hall Church Lane, Gawsworth SK11 9RQ Macclesfield Cheshire | British | 68445840001 | ||||||||||
| BRADDELL, John Roland Lyndhurst | Geschäftsführer | 1 Cholmondeley Walk TW9 1NS Richmond Surrey | England | British | 145923500001 | |||||||||
| DAY, Stevan | Geschäftsführer | 26 Kingsway PO11 0LZ Hayling Island Hampshire | British | 56385000001 | ||||||||||
| EMSLEY, Robert Wilfrid | Geschäftsführer | 4 Old School Orchard Watton At Stone SG14 3SS Hertford | United Kingdom | British | 59421120001 | |||||||||
| ENTWISTLE, Richard William | Geschäftsführer | Crossways Crays Pond RG8 7QE Goring Heath Oxfordshire | British | 50174710001 | ||||||||||
| FENTON, Christopher Victor | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 114610580002 | |||||||||
| GATEHOUSE, Howard Raymond | Geschäftsführer | 19 Heathside Place KT18 5TX Epsom Downs Surrey | British | 59684220002 | ||||||||||
| HALL, Simon John | Geschäftsführer | Bridge Cottage The Street Castle Eaton SN6 6JZ Swindon Wiltshire | British | 23997850003 | ||||||||||
| HALL, Simon John | Geschäftsführer | Bridge Cottage The Street Castle Eaton SN6 6JZ Swindon Wiltshire | British | 23997850003 | ||||||||||
| KAYSER, Michael Arthur | Geschäftsführer | 17 Hartsbourne Avenue WD23 1JP Bushey Heath Hertfordshire | United Kingdom | British | 141893610001 | |||||||||
| LEO, Jose | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | Spanish | 93348510004 | ||||||||||
| LINDEN, Brian Andrew | Geschäftsführer | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | United Kingdom | British | 36233000002 | |||||||||
| LOVE, Graham Carvell | Geschäftsführer | 4 Cranley Close GU1 2JN Guildford Surrey | British | 70683010001 | ||||||||||
| MICHIE, Serena Mary Ann | Geschäftsführer | 29b Thurloe Square SW7 2SD London | British | 51820880001 | ||||||||||
| MILLER, David John | Geschäftsführer | 1 Asmara Road NW2 3SS London | United Kingdom | British | 152304230002 | |||||||||
| MOGG, Charles Michael | Geschäftsführer | Ladywood Stray Church Road, Wilmcote CV37 9XD Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 87961010001 | ||||||||||
| PILBEAM, Michael | Geschäftsführer | Sloping Acre Lockeridge SN8 4ED Marlborough Wiltshire | British | 38883200001 | ||||||||||
| RAMSDALE, Robert Wyatt | Geschäftsführer | Rosemary Cottage Rosemary Lane Rowledge GU10 4DB Farnham Surrey | British | 51455750001 | ||||||||||
| STAPLES, Brian Lynn | Geschäftsführer | Pendle House Castle Hill Prestbury SK10 4AR Macclesfield Cheshire | United Kingdom | British | 55479560003 | |||||||||
| WAKELEY, Guy Richard, Dr | Geschäftsführer | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building Oxfordshire | British | 130873800001 | ||||||||||
| WEBSTER, Christopher Charles | Geschäftsführer | The Sherard Building Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford Oxfordshire | England | British | 154210550001 |
Hat COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Erstellt am 14. März 2003 Geliefert am 26. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 25. Apr. 1997 Geliefert am 01. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined) including the guarantee and debenture | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0