COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED

COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03334433
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    • (7032) /
    • (7222) /
    • (7230) /
    • (7514) /

    Wo befindet sich COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DSSD FM LIMITED22. Apr. 199722. Apr. 1997
    NEARCO LIMITED12. März 199712. März 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Juni 2010

    Kapitalaufstellung am 04. Juni 2010

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Christopher Webster als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Sherard Secretariat Services Limited am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten190

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    5 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer5615519
    109588620001
    DUGGAN, Gillian
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    EnglandBritish135453240001
    EWELL, Melvyn
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish61515760002
    NELSON, Andrew Latham
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish36191090003
    GATEHOUSE, Howard Raymond
    19 Heathside Place
    KT18 5TX Epsom Downs
    Surrey
    Sekretär
    19 Heathside Place
    KT18 5TX Epsom Downs
    Surrey
    British59684220002
    HUI, Carol
    Old Barn
    Petworth Road Witley
    GU8 5QW Godalming
    Surrey
    Sekretär
    Old Barn
    Petworth Road Witley
    GU8 5QW Godalming
    Surrey
    British72371980001
    MANTZ, Ann Elizabeth
    21 Four Wents
    KT11 2NE Cobham
    Surrey
    Sekretär
    21 Four Wents
    KT11 2NE Cobham
    Surrey
    British37441550001
    MICHIE, Serena Mary Ann
    29b Thurloe Square
    SW7 2SD London
    Sekretär
    29b Thurloe Square
    SW7 2SD London
    British51820880001
    RIDDLE, Gordon Henry
    22 The Hurdles
    Titchfield
    PO14 4AN Fareham
    Hampshire
    Sekretär
    22 The Hurdles
    Titchfield
    PO14 4AN Fareham
    Hampshire
    British55039990003
    TETLOW, John Richard
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    Sekretär
    Whittaker Court, Gawsworth New Hall
    Church Lane, Gawsworth
    SK11 9RQ Macclesfield
    Cheshire
    British68445840001
    BRADDELL, John Roland Lyndhurst
    1 Cholmondeley Walk
    TW9 1NS Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    1 Cholmondeley Walk
    TW9 1NS Richmond
    Surrey
    EnglandBritish145923500001
    DAY, Stevan
    26 Kingsway
    PO11 0LZ Hayling Island
    Hampshire
    Geschäftsführer
    26 Kingsway
    PO11 0LZ Hayling Island
    Hampshire
    British56385000001
    EMSLEY, Robert Wilfrid
    4 Old School Orchard
    Watton At Stone
    SG14 3SS Hertford
    Geschäftsführer
    4 Old School Orchard
    Watton At Stone
    SG14 3SS Hertford
    United KingdomBritish59421120001
    ENTWISTLE, Richard William
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Crossways Crays Pond
    RG8 7QE Goring Heath
    Oxfordshire
    British50174710001
    FENTON, Christopher Victor
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish114610580002
    GATEHOUSE, Howard Raymond
    19 Heathside Place
    KT18 5TX Epsom Downs
    Surrey
    Geschäftsführer
    19 Heathside Place
    KT18 5TX Epsom Downs
    Surrey
    British59684220002
    HALL, Simon John
    Bridge Cottage
    The Street Castle Eaton
    SN6 6JZ Swindon
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Bridge Cottage
    The Street Castle Eaton
    SN6 6JZ Swindon
    Wiltshire
    British23997850003
    HALL, Simon John
    Bridge Cottage
    The Street Castle Eaton
    SN6 6JZ Swindon
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Bridge Cottage
    The Street Castle Eaton
    SN6 6JZ Swindon
    Wiltshire
    British23997850003
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritish141893610001
    LEO, Jose
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Spanish93348510004
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Geschäftsführer
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    United KingdomBritish36233000002
    LOVE, Graham Carvell
    4 Cranley Close
    GU1 2JN Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Cranley Close
    GU1 2JN Guildford
    Surrey
    British70683010001
    MICHIE, Serena Mary Ann
    29b Thurloe Square
    SW7 2SD London
    Geschäftsführer
    29b Thurloe Square
    SW7 2SD London
    British51820880001
    MILLER, David John
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    Geschäftsführer
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    United KingdomBritish152304230002
    MOGG, Charles Michael
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British87961010001
    PILBEAM, Michael
    Sloping Acre
    Lockeridge
    SN8 4ED Marlborough
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Sloping Acre
    Lockeridge
    SN8 4ED Marlborough
    Wiltshire
    British38883200001
    RAMSDALE, Robert Wyatt
    Rosemary Cottage Rosemary Lane
    Rowledge
    GU10 4DB Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Rosemary Cottage Rosemary Lane
    Rowledge
    GU10 4DB Farnham
    Surrey
    British51455750001
    STAPLES, Brian Lynn
    Pendle House
    Castle Hill Prestbury
    SK10 4AR Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Pendle House
    Castle Hill Prestbury
    SK10 4AR Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish55479560003
    WAKELEY, Guy Richard, Dr
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Oxfordshire
    British130873800001
    WEBSTER, Christopher Charles
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish154210550001

    Hat COMAX SECURE BUSINESS SERVICES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 14. März 2003
    Geliefert am 26. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee on Behalf of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 26. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 25. Apr. 1997
    Geliefert am 01. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined) (the"Security Trustee")
    Transaktionen
    • 01. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0