NORDIC PIONEER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNORDIC PIONEER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03339845
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NORDIC PIONEER LIMITED?

    • Sonstige Bildung n.n.g. (85590) / Erziehung
    • Bildungsunterstützende Dienstleistungen (85600) / Erziehung

    Wo befindet sich NORDIC PIONEER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4 Carlton Court
    Brown Lane West
    LS12 6LT Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORDIC PIONEER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für NORDIC PIONEER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    24 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Okt. 2017

    35 SeitenLIQ03

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    3 SeitenF10.2

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    12 Seiten4.20

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Nftg Training Academy 1 Chesnut Street Darlington County Durham DL1 1QL zum 4 Carlton Court Brown Lane West Leeds West Yorkshire LS12 6LT am 25. Okt. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 11. Okt. 2016

    LRESEX

    Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 26. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 262.999376
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2015

    8 SeitenAA

    Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 15. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 263.0
    4 SeitenSH06

    Eigenkapitalrückkauf.

    3 SeitenSH03

    Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 28. Nov. 2014

    • Kapital: GBP 272.0
    4 SeitenSH06

    Eigenkapitalrückkauf.

    3 SeitenSH03

    Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 03. Aug. 2015

    • Kapital: GBP 266.4
    4 SeitenSH06

    Eigenkapitalrückkauf.

    3 SeitenSH03

    Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. März 2015

    Kapitalaufstellung am 26. März 2015

    • Kapital: GBP 273.4
    SH01

    Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Nftg Training Academy 1 Chesnut Street Darlington County Durham DL1 1QL verlegt

    1 SeitenAD04

    Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 24. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 273.0
    4 SeitenSH06

    Eigenkapitalrückkauf.

    3 SeitenSH03

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2014

    9 SeitenAA

    Eigenkapitalrückkauf.

    3 SeitenSH03

    Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 29. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 274
    4 SeitenSH06

    Wer sind die Geschäftsführer von NORDIC PIONEER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROOKS, Kuldip Kaur
    Portchester Close
    Ingleby Barwick
    TS17 5LQ Stockton-On-Tees
    15
    Cleveland
    England
    Geschäftsführer
    Portchester Close
    Ingleby Barwick
    TS17 5LQ Stockton-On-Tees
    15
    Cleveland
    England
    EnglandBritishBusiness Advisor92372480002
    ROBINSON, Peter
    11 Hartlea Avenue
    DL1 3NE Darlington
    County Durham
    Geschäftsführer
    11 Hartlea Avenue
    DL1 3NE Darlington
    County Durham
    United KingdomBritishCompany Director108623750001
    MULLETT, Geoffrey William
    Blossomfields
    Exhall
    B49 6EA Warwickshire
    Sekretär
    Blossomfields
    Exhall
    B49 6EA Warwickshire
    British51809080003
    MULLETT, Geoffrey William
    15 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    Sekretär
    15 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    British51809080002
    SEED, Kevin
    105 Wimpole Road
    TS19 7LR Stockton On Tees
    Cleveland
    Sekretär
    105 Wimpole Road
    TS19 7LR Stockton On Tees
    Cleveland
    British64238780001
    SHAKESPEARE, Diane Susan
    The Meadows
    Middleton St. George
    DL2 1UE Darlington
    16
    County Durham
    England
    Sekretär
    The Meadows
    Middleton St. George
    DL2 1UE Darlington
    16
    County Durham
    England
    147148850001
    HUTCHINSON, Alan Leslie
    40 Regency Gardens
    Euxton
    PR7 6NW Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    40 Regency Gardens
    Euxton
    PR7 6NW Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector49898380003
    MULLETT, Geoffrey William
    Blossomfields
    B49 6EA Exhall
    Blossomfields
    Warwickshire
    England
    Geschäftsführer
    Blossomfields
    B49 6EA Exhall
    Blossomfields
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritishConsultant51809080003
    MULLETT, Geoffrey William
    Blossomfields
    Exhall
    B49 6EA Warwickshire
    Geschäftsführer
    Blossomfields
    Exhall
    B49 6EA Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director51809080003
    SHAKESPEARE, Diane Susan
    The Meadows
    DL2 1UE Middleton St George
    16
    Darlington
    England
    Geschäftsführer
    The Meadows
    DL2 1UE Middleton St George
    16
    Darlington
    England
    United KingdomBritishOperations Director182106380001
    SHEA, Michael Sinclair, Dr
    1a Ramsay Garden
    EH1 2NA Edinburgh
    Geschäftsführer
    1a Ramsay Garden
    EH1 2NA Edinburgh
    BritishCompany Director38326850001
    VARLEY, Cameron Joseph
    Milestone Farm
    56-58 Westgate North Cave
    HU15 2NJ Hull
    East Riding Of Yorkshire
    Geschäftsführer
    Milestone Farm
    56-58 Westgate North Cave
    HU15 2NJ Hull
    East Riding Of Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director158189460001

    Hat NORDIC PIONEER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 24. März 2014
    Geliefert am 25. März 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 25. März 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juni 2012
    Geliefert am 30. Juni 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 30. Juni 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Juli 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 04. Jan. 2012
    Geliefert am 07. Jan. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hitachi Capital (UK) PLC T/as Hitachi Capital Invoice Finance
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 27. Okt. 2006
    Geliefert am 31. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Mai 2004
    Geliefert am 02. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    All assets debenture
    Erstellt am 18. Feb. 2004
    Geliefert am 26. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cattles Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 18. März 2003
    Geliefert am 27. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 27. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NORDIC PIONEER LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    11. Okt. 2016Beginn der Liquidation
    04. Apr. 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    James Sleight
    Geoffrey Martin & Co. 4 Carlton Court Brown Lane West
    LS12 6LT Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Geoffrey Martin & Co. 4 Carlton Court Brown Lane West
    LS12 6LT Leeds
    West Yorkshire
    John H Twizell
    Geoffrey Martin & Co. 4 Carlton Court
    Brown Lane West
    LS12 6LT Leeds
    Praktiker
    Geoffrey Martin & Co. 4 Carlton Court
    Brown Lane West
    LS12 6LT Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0