RIVERSIDE CROYDON LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RIVERSIDE CROYDON LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03340555 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RIVERSIDE CROYDON LIMITED?
- Fitnessstudios (93130) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
Wo befindet sich RIVERSIDE CROYDON LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o MAZARS LLP 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RIVERSIDE CROYDON LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RIVERSIDE CROYDON LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für RIVERSIDE CROYDON LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE England geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , Active House 21 North Fourth Street, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 1HL am 09. Okt. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 19. Sept. 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Antony Woolf als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Norman Field als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Matthew Graham Merrick als Direktor | 4 Seiten | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von James Archibald als Sekretär | 4 Seiten | AP03 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von James Archibald als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Matthew Graham Merrick als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RIVERSIDE CROYDON LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHIBALD, James | Sekretär | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | British | 162966660001 | ||||||
| BUCKNALL, Matthew William | Geschäftsführer | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | United Kingdom | British | 162066820001 | |||||
| MERRICK, Matthew Graham | Geschäftsführer | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | United Kingdom | British | 162110530001 | |||||
| WOOLF, Paul Antony | Geschäftsführer | c/o Mazars Llp Church Street B3 2RT Birmingham 45 | United Kingdom | British | 160679880001 | |||||
| ASHWORTH, Paul Richard | Sekretär | 118 St Anns Hill Wandsworth SW18 2RR London | British | 46410260001 | ||||||
| BALL, Michael David | Sekretär | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | British | 58961410002 | ||||||
| DREGENT, Patricia Ann Taylor | Sekretär | 17 Spinney Close RM13 8LR Rainham Essex | British | 6369240002 | ||||||
| PENRICE, Victoria Margaret | Sekretär | Trebartha 51a Frances Road SL4 3AQ Windsor Berkshire | British | 90459300001 | ||||||
| SCALES, Eugene Patrick | Sekretär | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | Other | 124193970001 | ||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Sekretär | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||
| TYSON, Roger Thomas Virley | Sekretär | 2 Gadd Close RG40 5PQ Wokingham Berkshire | British | 113777700001 | ||||||
| WHEELER, Jonathan | Sekretär | 19 Glebe Place Chelsea SW3 5LD London | British | 19812400001 | ||||||
| WONG, Wai Chung | Sekretär | Flat 3 Rowsley Lodge 72a Lady Margaret Road N19 5EL London | British | 123616460002 | ||||||
| ANDERSON, Ruth | Geschäftsführer | 46 Upper Grotto Road Strawberry Hill TW1 4NF Twickenham | British | 66859670001 | ||||||
| ASHWORTH, Paul Richard | Geschäftsführer | 118 St Anns Hill Wandsworth SW18 2RR London | England | British | 46410260001 | |||||
| BALL, Michael David | Geschäftsführer | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 58961410002 | |||||
| BEADLE, Mark Ronald Sydney | Geschäftsführer | 14 Fen Meadow TN15 9HT Ightham Kent | British | 80515670001 | ||||||
| CHARLTON, Stephen Paul | Geschäftsführer | 9 Rowan Close L40 4LP Burscough Lancashire | England | British | 96743210001 | |||||
| CLELAND, Jonathan Bradley | Geschäftsführer | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 146698270001 | |||||
| COLES, Charles Graham | Geschäftsführer | Willow Cottage Chalfont Lane WD3 5PP Chorleywood Hertfordshire | England | British | 12337010002 | |||||
| CREED, Stuart John | Geschäftsführer | Jade House The Avenue Claverton Down BA2 7AX Bath | United Kingdom | British | 3716600001 | |||||
| DHODY, Jog | Geschäftsführer | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 104269910002 | |||||
| FIELD, Norman Mark | Geschäftsführer | North Fourth Street MK9 1HL Milton Keynes Active House 21 Buckinghamshire | United Kingdom | South African | 161860310001 | |||||
| FOSTER, Michael Raymond | Geschäftsführer | 4 Church Close Westoning MK45 5DH Bedford | England | British | 53280440001 | |||||
| GILLIS, Neil Duncan | Geschäftsführer | Lodge Farm High Street, Thelnetham IP22 1JL Diss Norfolk | England | British | 69204500003 | |||||
| GUYER, Paul John | Geschäftsführer | Oakwood House 29 Leydene Park GU32 1HF East Meon Hampshire | British | 100971720002 | ||||||
| HALL, Andrew James | Geschäftsführer | Tanglewood 3 Badingham Drive AL5 2DA Harpenden Hertfordshire | England | British | 30306840002 | |||||
| HENCHOZ, Patrick | Geschäftsführer | Huntington Court Huntington Lane HR4 7RA Hereford Herefordshire | United Kingdom | Swiss | 93431850001 | |||||
| JOHNSON, Mark Christopher | Geschäftsführer | Little Stream Sunning Hill Road SL5 9JZ Ascot Berkshire | England | British | 48443030001 | |||||
| KELLY, Maurice William | Geschäftsführer | Spinney Cottage Wing Road Mentmore LU7 0QG Leighton Buzzard Buckinghamshire | British | 89366130001 | ||||||
| LEATHERBARROW, David Jon | Geschäftsführer | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | England | British | 135618280002 | |||||
| MCCOLLUM, Kevin Boyd | Geschäftsführer | Waterton Stables Ampney Crucis GL7 5RX Cirencester Gloucestershire | England | British | 121972580001 | |||||
| MCGUIGAN, Marc Edward | Geschäftsführer | Avadi Chapel Lane GL20 7ER Tewkesbury Gloucester | England | British | 93677590002 | |||||
| MCRORY, Penelope Ann | Geschäftsführer | 13 Queen Street KT16 8BS Chertsey Surrey | British | 52251860001 | ||||||
| MICHAELS, Terry | Geschäftsführer | The Vines Hardwick Close KT22 0HZ Oxshott Surrey | New Zealand | 72228080001 |
Hat RIVERSIDE CROYDON LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating security document | Erstellt am 18. Juni 2009 Geliefert am 26. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Group debenture | Erstellt am 08. Feb. 2006 Geliefert am 18. Feb. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Jan. 2004 Geliefert am 07. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any other member of the group to the note finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Jan. 2004 Geliefert am 03. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower, the charging group and/or any member of the group (meaning the borrower or its subsidiaries from time to time) to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Dukes meadow chiswick hounslow t/no NGL147830; imperial way croydon surrey t/no SGL454522; llandarcy neath swansea t/no CYM43829 and WA953690 for details of further properties charged please refer to form 395 unscheduled property, rental income, fixed or other plant and machinery, insurances, licences on land, reights as tenant, book and other debts, bank accounts, charged securities, uncalled capital , goodwill, intellectual property, licences, credit agreements, contracts floating charge undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat RIVERSIDE CROYDON LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0