RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03341350 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?
- Kombinierte Unterstützungsdienste für Einrichtungen (81100) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
- Andere Reinigungsdienste (81299) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kpmg 8 Princes Parade L3 1QH Liverpool |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CARILLION PALL MALL LIMITED | 31. Mai 2006 | 31. Mai 2006 |
MOWLEM PALL MALL LIMITED | 10. Feb. 2004 | 10. Feb. 2004 |
PALL MALL SUPPORT SERVICES LIMITED | 03. Apr. 1997 | 03. Apr. 1997 |
TRUSHELFCO (NO.2227) LIMITED | 27. März 1997 | 27. März 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 22 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. März 2020 | 24 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 9 Seiten | LIQ10 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. März 2019 | 26 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. März 2018 | 24 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Innovation House Bullerthorpe Lane Colton Leeds West Yorkshire LS15 9JL zum Kpmg 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH am 29. Mai 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. März 2017 | 13 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. März 2017 | 13 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 1 Seiten | 2.34B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. März 2016 | 16 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Sept. 2015 | 14 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. März 2015 | 26 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 25 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 29 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 29 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Richard William Taylor Gray am 05. Sept. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr John King als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Seaton als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 33 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DANIEL, Mark Richard | Sekretär | 8 Princes Parade L3 1QH Liverpool Kpmg | 178838610001 | |||||||
FORAN, Raymond Christopher | Geschäftsführer | 8 Princes Parade L3 1QH Liverpool Kpmg | Ireland | Irish | Company Director | 149366250001 | ||||
GRAY, Richard William Taylor | Geschäftsführer | 8 Princes Parade L3 1QH Liverpool Kpmg | Scotland | British | Director | 111454800002 | ||||
KING, John | Geschäftsführer | 8 Princes Parade L3 1QH Liverpool Kpmg | Ireland | Irish | Company Director | 184461620001 | ||||
BARKER, Nigel | Sekretär | Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds Innovation House West Yorkshire | British | 153013180001 | ||||||
FOSTER, Robert | Sekretär | 9 Ganton Road Bloxwich WS3 3XQ Walsall | British | Director | 38619010002 | |||||
HARKIN, Niall | Sekretär | 5 Campbell Chase BT4 3PE Belfast County Antrim N Ireland | British | Finance Director | 125430560001 | |||||
LAWRENCE, David | Sekretär | 45 Griffith Avenue Drumcondra Dublin 9 Republic Of Ireland | British | 136692630001 | ||||||
MACNAMARA, James Justin | Sekretär | Heyford Manor 18 Church Lane, Lower Heyford OX25 5NZ Oxon | British | Finance Director | 204243460001 | |||||
CARILLION SECRETARIAT LIMITED | Sekretär | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton West Midlands | 33743910002 | |||||||
TRUSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | 900007200001 | |||||||
BEAN, Paul Francis | Geschäftsführer | 10 Ormiston Farm Steadings Kirknewton EH27 0DQ Edinburgh West Lothian | United Kingdom | British | Company Director | 125759470001 | ||||
BOYLE, George Mathieson | Geschäftsführer | Strathern House Devonshire Avenue HP6 5JE Amersham Buckinghamshire | British | Director | 102046460001 | |||||
BRANNIGAN, Terence Hugh | Geschäftsführer | West Cliffe Grove HG2 0PS Harrogate 17 North Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 125430930001 | ||||
DAY, Stephen John | Geschäftsführer | Becca House Becca Lane Aberford LS25 3BD Leeds | England | British | Director | 59028300002 | ||||
FORAN, Raymond Christopher | Geschäftsführer | Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds Innovation House West Yorkshire | Ireland | Irish | Director | 149366250001 | ||||
FOSTER, Robert | Geschäftsführer | 9 Ganton Road Bloxwich WS3 3XQ Walsall | England | British | Director | 38619010002 | ||||
HARKIN, Niall | Geschäftsführer | 5 Campbell Chase BT4 3PE Belfast County Antrim N Ireland | Northern Ireland | British | Finance Director | 125430560001 | ||||
IVEY, John Charles | Geschäftsführer | Tregenna 32 The Glen Farnborough Park BR6 8LR Orpington Kent | British | Director | 8286080001 | |||||
MACNAMARA, James Justin | Geschäftsführer | Heyford Manor 18 Church Lane, Lower Heyford OX25 5NZ Oxon | England | British | Director | 204243460001 | ||||
MCGRORY, Jack | Geschäftsführer | 12 Woodlands Park Scarcroft LS14 3JU Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 96596920001 | ||||
ROWE, Drusilla Charlotte Jane | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat E 13 Saint Georges Drive SW1V 4DJ London | British | 900010990001 | ||||||
SEATON, David John | Geschäftsführer | Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds Innovation House West Yorkshire | England | British | Director | 66233040004 | ||||
SHEPLEY, Philip Ernest | Geschäftsführer | 15 Whitmore Road Beckenham BR3 3NU Kent | United Kingdom | British | Customer Services Director | 122662180001 | ||||
VAUGHAN, Andrew David | Geschäftsführer | Bullerthorpe Lane Colton LS15 9JL Leeds Innovation House West Yorkshire | England | British | Director | 110679680001 | ||||
VOCKINS, Anthony Frederick | Geschäftsführer | 3 Shires Orchard Croxton Kerral NG32 1RD Grantham Lincolnshire | British | Managing Director | 123410850001 | |||||
WOODS, David | Geschäftsführer | 12 Rainsborough Rise Thorpe St Andrew NR7 0TR Norwich Norfolk | British | Director | 11156100002 | |||||
ZUERCHER, Eleanor Jane | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 26 Springfield Road Linslade LU7 7QS Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 900014530001 | ||||||
CARILLION MANAGEMENT LIMITED | Geschäftsführer | 24 Birch Street WV1 4HY Wolverhampton West Midlands | 36778210004 |
Hat RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Erstellt am 23. Dez. 2010 Geliefert am 08. Jan. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A first fixed equitable charge over the deposit balance being the balance from time to time standing to the credit of the deposit account being a separate interest bearing account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 28. Sept. 2007 Geliefert am 19. Okt. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the comapny to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 02. Juni 2000 Geliefert am 16. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due or to become due from the parent company (as defined) or the company to the chargee (the "security trustee") as trustee for itself and the noteholders under or in connection with the notes (as defined) or the mortgage debenture together with the expenses (as defined) | |
Kurze Angaben 141/157 acre lane brixton london; rooms 36-37 first floor lingley house commissioners road streed kent; 1 st michaels court church street newport gwent .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 02. Juni 2000 Geliefert am 14. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever under the financing documents or otherwise | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 07. Nov. 1997 Geliefert am 15. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies, obligations and liabilities due or to become due from any company to the chargee and to any beneficiary (as defined) under or in connection with the notes (as defined) or this deed | |
Kurze Angaben 141/157 acre lane brixton london; rooms 36/37 first floor lingley house, commissioners road strood kent; unit 3 evtol trading estate portland street, newport gwent .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 07. Nov. 1997 Geliefert am 12. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and on any account whatsoever under the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0