RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED

RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03341350
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    • Kombinierte Unterstützungsdienste für Einrichtungen (81100) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
    • Andere Reinigungsdienste (81299) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CARILLION PALL MALL LIMITED31. Mai 200631. Mai 2006
    MOWLEM PALL MALL LIMITED10. Feb. 200410. Feb. 2004
    PALL MALL SUPPORT SERVICES LIMITED03. Apr. 199703. Apr. 1997
    TRUSHELFCO (NO.2227) LIMITED27. März 199727. März 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    22 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. März 2020

    24 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    9 SeitenLIQ10

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. März 2019

    26 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. März 2018

    24 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Innovation House Bullerthorpe Lane Colton Leeds West Yorkshire LS15 9JL zum Kpmg 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH am 29. Mai 2018

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. März 2017

    13 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. März 2017

    13 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. März 2016

    16 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. Sept. 2015

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 17. März 2015

    26 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    25 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    29 Seiten2.17B

    Vorschlag des Verwalters

    29 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard William Taylor Gray am 05. Sept. 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 27. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 08. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 1,000,003
    SH01

    Ernennung von Mr John King als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Seaton als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    33 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DANIEL, Mark Richard
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Sekretär
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    178838610001
    FORAN, Raymond Christopher
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Geschäftsführer
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    IrelandIrishCompany Director149366250001
    GRAY, Richard William Taylor
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Geschäftsführer
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    ScotlandBritishDirector111454800002
    KING, John
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    Geschäftsführer
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Kpmg
    IrelandIrishCompany Director184461620001
    BARKER, Nigel
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Sekretär
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    British153013180001
    FOSTER, Robert
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    Sekretär
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    BritishDirector38619010002
    HARKIN, Niall
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Sekretär
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    BritishFinance Director125430560001
    LAWRENCE, David
    45 Griffith Avenue
    Drumcondra
    Dublin 9
    Republic Of Ireland
    Sekretär
    45 Griffith Avenue
    Drumcondra
    Dublin 9
    Republic Of Ireland
    British136692630001
    MACNAMARA, James Justin
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    Sekretär
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    BritishFinance Director204243460001
    CARILLION SECRETARIAT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    Sekretär
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    33743910002
    TRUSEC LIMITED
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    Bevollmächtigter Sekretär
    35 Basinghall Street
    EC2V 5DB London
    900007200001
    BEAN, Paul Francis
    10 Ormiston Farm Steadings
    Kirknewton
    EH27 0DQ Edinburgh
    West Lothian
    Geschäftsführer
    10 Ormiston Farm Steadings
    Kirknewton
    EH27 0DQ Edinburgh
    West Lothian
    United KingdomBritishCompany Director125759470001
    BOYLE, George Mathieson
    Strathern House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Strathern House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JE Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector102046460001
    BRANNIGAN, Terence Hugh
    West Cliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    17
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    West Cliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    17
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director125430930001
    DAY, Stephen John
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    Geschäftsführer
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    EnglandBritishDirector59028300002
    FORAN, Raymond Christopher
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    IrelandIrishDirector149366250001
    FOSTER, Robert
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    Geschäftsführer
    9 Ganton Road
    Bloxwich
    WS3 3XQ Walsall
    EnglandBritishDirector38619010002
    HARKIN, Niall
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Geschäftsführer
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Northern IrelandBritishFinance Director125430560001
    IVEY, John Charles
    Tregenna 32 The Glen
    Farnborough Park
    BR6 8LR Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    Tregenna 32 The Glen
    Farnborough Park
    BR6 8LR Orpington
    Kent
    BritishDirector8286080001
    MACNAMARA, James Justin
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    Geschäftsführer
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    EnglandBritishDirector204243460001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector96596920001
    ROWE, Drusilla Charlotte Jane
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Flat E
    13 Saint Georges Drive
    SW1V 4DJ London
    British900010990001
    SEATON, David John
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector66233040004
    SHEPLEY, Philip Ernest
    15 Whitmore Road
    Beckenham
    BR3 3NU Kent
    Geschäftsführer
    15 Whitmore Road
    Beckenham
    BR3 3NU Kent
    United KingdomBritishCustomer Services Director122662180001
    VAUGHAN, Andrew David
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector110679680001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    3 Shires Orchard
    Croxton Kerral
    NG32 1RD Grantham
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    3 Shires Orchard
    Croxton Kerral
    NG32 1RD Grantham
    Lincolnshire
    BritishManaging Director123410850001
    WOODS, David
    12 Rainsborough Rise
    Thorpe St Andrew
    NR7 0TR Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    12 Rainsborough Rise
    Thorpe St Andrew
    NR7 0TR Norwich
    Norfolk
    BritishDirector11156100002
    ZUERCHER, Eleanor Jane
    26 Springfield Road
    Linslade
    LU7 7QS Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    26 Springfield Road
    Linslade
    LU7 7QS Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British900014530001
    CARILLION MANAGEMENT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    36778210004

    Hat RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 23. Dez. 2010
    Geliefert am 08. Jan. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first fixed equitable charge over the deposit balance being the balance from time to time standing to the credit of the deposit account being a separate interest bearing account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Pollen Estate Trustee Company Limited
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 19. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the comapny to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 02. Juni 2000
    Geliefert am 16. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the parent company (as defined) or the company to the chargee (the "security trustee") as trustee for itself and the noteholders under or in connection with the notes (as defined) or the mortgage debenture together with the expenses (as defined)
    Kurze Angaben
    141/157 acre lane brixton london; rooms 36-37 first floor lingley house commissioners road streed kent; 1 st michaels court church street newport gwent .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wren Investments Limited
    Transaktionen
    • 16. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 02. Juni 2000
    Geliefert am 14. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever under the financing documents or otherwise
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 07. Nov. 1997
    Geliefert am 15. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from any company to the chargee and to any beneficiary (as defined) under or in connection with the notes (as defined) or this deed
    Kurze Angaben
    141/157 acre lane brixton london; rooms 36/37 first floor lingley house, commissioners road strood kent; unit 3 evtol trading estate portland street, newport gwent .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wren Investments Limited (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 15. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 07. Nov. 1997
    Geliefert am 12. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat RESOURCE (UNITED KINGDOM) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Sept. 2014Beginn der Verwaltung
    24. März 2016Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Praktiker
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Stuart Irwin
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Praktiker
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    2
    DatumTyp
    24. März 2016Beginn der Liquidation
    04. Nov. 2020Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian Leonard
    1 Lanyon Place
    BT1 3LP Belfast
    County Antrim
    Praktiker
    1 Lanyon Place
    BT1 3LP Belfast
    County Antrim
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Vorgeschlagener Liquidator
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Stuart Irwin
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Vorgeschlagener Liquidator
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Stuart Irwin
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    Praktiker
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    County Antrim
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    Praktiker
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0