MAXIM POINT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MAXIM POINT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03346112 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MAXIM POINT LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MAXIM POINT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Silk House Park Green SK11 7QW Macclesfield Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAXIM POINT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MAXIM POINT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Cessation of Gnosall Health Care Limited as a person with significant control on 01. Aug. 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Bhupinder Singh Cooner as a person with significant control on 01. Aug. 2017 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tina Louise Westwood als Geschäftsführer am 01. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Charles Greaves als Geschäftsführer am 01. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael John Mulligan als Geschäftsführer am 31. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Doctor Michael John Mulligan am 31. Mai 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MAXIM POINT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COONER, Bhupinder Singh, Dr | Sekretär | 4 Beechcroft Grange ST16 1BD Stafford Staffordshire | British | 97048700001 | ||||||
| COONER, Bhupinder Singh, Dr | Geschäftsführer | 4 Beechcroft Grange ST16 1BD Stafford Staffordshire | England | British | 97048700001 | |||||
| COONER, Perminder Kaur | Sekretär | 2 Willow Brook Derrington ST18 9NN Stafford | British | 58987880002 | ||||||
| SELLWOOD, Vivenne Jane | Sekretär | Gobions Brook Lane ST18 9JY Stafford Staffordshire | British | 53460700001 | ||||||
| FNCS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Churchill Way CF1 4DX Cardiff | 900011830001 | |||||||
| COONER, Perminder Kaur | Geschäftsführer | 2 Willow Brook Derrington ST18 9NN Stafford | British | 58987880002 | ||||||
| GREAVES, Ian Charles, Dr | Geschäftsführer | Shushions Manor Church Eaton ST20 0AB Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | 48647400003 | |||||
| HENDERSON, Patricia Rosemary | Geschäftsführer | 2 North Road Gardens SG14 1NH Hertford Hertfordshire | British | 60542320001 | ||||||
| MULLIGAN, Michael John, Doctor | Geschäftsführer | 55 Baswich Crest ST17 0HJ Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | 53846330001 | |||||
| PHILLIPS, Louise | Geschäftsführer | 46 Post Office Lane TF10 9DR Newport Salop | British | 53460640001 | ||||||
| WESTWOOD, Tina Louise | Geschäftsführer | 12a Grosvenor Close Penkridge ST19 5BS Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | 49130810001 | |||||
| WESTWOOD, William Leslie | Geschäftsführer | Brinwood 1 Grosvenor Close Penkridge ST19 5BS Stafford Staffordshire | British | 60542430001 | ||||||
| WILLIAMS, Barrie | Geschäftsführer | 8 The Flashes Gnosall ST20 0HJ Stafford Staffordshire | British | 66046890001 | ||||||
| FNCS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 16 Churchill Way CF1 4DX Cardiff | 900011820001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MAXIM POINT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Bhupinder Singh Cooner | 01. Aug. 2017 | Silk House Park Green SK11 7QW Macclesfield Cheshire | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Gnosall Health Care Limited | 06. Apr. 2016 | Brookhouse Road Gnosall ST20 0GP Stafford Gnosall Health Centre England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MAXIM POINT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 04. Feb. 2002 Geliefert am 20. Feb. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property at 3 hamilton lea brownhills road norton canes cannock straffordshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Juni 2000 Geliefert am 24. Juni 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture | |
Kurze Angaben 9 brownlow rd,london and 312 high rd,wood green,london. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 29. Feb. 2000 Geliefert am 04. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property at 24 high street gnosall staffordshire.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 29. Feb. 2000 Geliefert am 04. März 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property at 60 brownhills road norton canes cannock staffordshire.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Nov. 1998 Geliefert am 06. Nov. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0