STEPHIGH LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTEPHIGH LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03346861
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STEPHIGH LTD?

    • (8514) /

    Wo befindet sich STEPHIGH LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KPMG RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STEPHIGH LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für STEPHIGH LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Mai 2010

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Bridge House, Outwood Lane Horsforth Leeds LS18 4UP am 16. Juni 2010

    2 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Simon Reiter als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Ellerby als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    10 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 13. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Apr. 2010

    Kapitalaufstellung am 28. Apr. 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Nicholas Tetley Beazley am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Änderung der Details des Direktors für Simon Philip Reiter am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mahboob Ali Merchant am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mark Ellerby am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    10 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 07/01/2009
    RES13

    legacy

    1 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von STEPHIGH LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Sekretär
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Geschäftsführer
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270003
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish56732410001
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Sekretär
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    British10012650001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Sekretär
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    MASONS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    30 Aylesbury Street
    EC1R 0ER London
    Sekretär
    30 Aylesbury Street
    EC1R 0ER London
    32643220001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Sekretär
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    34893920001
    CLINTON, David
    Breen Cottage
    63 Station Road
    AB31 5UD Banchory
    Kincardineshire
    Geschäftsführer
    Breen Cottage
    63 Station Road
    AB31 5UD Banchory
    Kincardineshire
    United KingdomBritish30279690002
    DALY, Geoffrey William Stuart
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    United KingdomBritish19464860003
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DHANDSA, Narinder, Dr
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    Geschäftsführer
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    EnglandBritish115844000001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    HOUGHTON, George
    Pine Dene
    Dissington Lane
    NE15 0AE Ponteland
    Northumerland
    Geschäftsführer
    Pine Dene
    Dissington Lane
    NE15 0AE Ponteland
    Northumerland
    United KingdomBritish29555780001
    HOUGHTON, George
    Tyne View House Askew Road West
    NE8 2JX Gateshead
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Tyne View House Askew Road West
    NE8 2JX Gateshead
    Tyne & Wear
    British52580210003
    HOUGHTON, Jennifer Pamela
    Primrose Lodge
    Dissington Lane
    NE15 0AB Ponteland
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Primrose Lodge
    Dissington Lane
    NE15 0AB Ponteland
    Northumberland
    EnglandBritish48281920002
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    LUKE, George, Mr.
    4 Kirkside
    New Herrington
    DH4 4NX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    4 Kirkside
    New Herrington
    DH4 4NX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    EnglandBritish45765040001
    REITER, Simon Philip
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    Geschäftsführer
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    United KingdomBritish135845570001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Geschäftsführer
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritish62846800003
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001
    ANS NOMINEES LIMITED
    1 Battersea Square
    SW11 3PZ London
    Geschäftsführer
    1 Battersea Square
    SW11 3PZ London
    68699250001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    Hat STEPHIGH LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 09. Jan. 2004
    Geliefert am 14. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 14. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 2001
    Geliefert am 11. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) whether for its own account or as trustee for the secured parties (as defined) or any of the other secured parties including any liability in respect of any further advances made under the facility (as defined) or the mezzanine loan facility (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Mai 1997
    Geliefert am 20. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a eye hospital wilton avenue southamptom t/no HP422098 goodwill and proceeds of insurance thereon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 08. Mai 1997
    Geliefert am 10. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    1). f/h land and buildings k/a summerlands lodge nursing home 123 canterbury road westgage on sea keny t/no;-0K571115 2). f/h land and buildings k/a warrens hall nursing mhome 218 oakham road tividale warley west midlands t/no;-WM459415 3). f/h land k/a the site of the former eye hospital wilton avenue southampton t/no;-HP422098 any other property belonging or charged to the company during the contuance of this security all stocks shares and related rights all book and other debts goodwill and benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Associated Nursing Services PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 1997
    Geliefert am 20. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 218 oakham road tividale warley west midlands t/no;-WM459415 goodwill andthe proceeds of insurance thereon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 1997
    Geliefert am 20. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a piper house 123 canterbury road westgate -on-sea t/no;-K571115 goodwill and the proceeds of insurance thereof. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Mai 1997
    Geliefert am 14. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat STEPHIGH LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Jan. 2011Aufgelöst am
    26. Mai 2010Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0