STEPHIGH LTD
Überblick
| Unternehmensname | STEPHIGH LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03346861 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von STEPHIGH LTD?
- (8514) /
Wo befindet sich STEPHIGH LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | KPMG RESTRUCTURING 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STEPHIGH LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für STEPHIGH LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bridge House, Outwood Lane Horsforth Leeds LS18 4UP am 16. Juni 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Reiter als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Ellerby als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 13. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicholas Tetley Beazley am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon Philip Reiter am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mahboob Ali Merchant am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Ellerby am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von STEPHIGH LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bupa House 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London | 107319700001 | |||||||
| BEAZLEY, Nicholas Tetley | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 105797560001 | |||||
| GREGORY, Fraser David | Geschäftsführer | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | 107664270003 | |||||
| MERCHANT, Mahboob Ali | Geschäftsführer | 28 Denham Road KT17 3AA Epsom Surrey | United Kingdom | British | 56732410001 | |||||
| KING, Robert Frederick | Sekretär | 8 Prior Bolton Street Canonbury N1 2NX London | British | 10012650001 | ||||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
| MASONS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 30 Aylesbury Street EC1R 0ER London | 32643220001 | |||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Sekretär | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 34893920001 | |||||||
| CLINTON, David | Geschäftsführer | Breen Cottage 63 Station Road AB31 5UD Banchory Kincardineshire | United Kingdom | British | 30279690002 | |||||
| DALY, Geoffrey William Stuart | Geschäftsführer | Sixpenny Buckle Coldhouse Hill GU22 0QS Woking Surrey | United Kingdom | British | 19464860003 | |||||
| DAVIES, Julian Peter | Geschäftsführer | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 29367700001 | |||||
| DHANDSA, Narinder, Dr | Geschäftsführer | D102 Montevetro 100 Battersea Church Road Battersea SW11 3YL London | England | British | 115844000001 | |||||
| ELLERBY, Mark | Geschäftsführer | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | 40582650004 | |||||
| HOUGHTON, George | Geschäftsführer | Pine Dene Dissington Lane NE15 0AE Ponteland Northumerland | United Kingdom | British | 29555780001 | |||||
| HOUGHTON, George | Geschäftsführer | Tyne View House Askew Road West NE8 2JX Gateshead Tyne & Wear | British | 52580210003 | ||||||
| HOUGHTON, Jennifer Pamela | Geschäftsführer | Primrose Lodge Dissington Lane NE15 0AB Ponteland Northumberland | England | British | 48281920002 | |||||
| KENT, Benjamin David Jemphrey | Geschäftsführer | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 93897360003 | |||||
| LUKE, George, Mr. | Geschäftsführer | 4 Kirkside New Herrington DH4 4NX Houghton Le Spring Tyne & Wear | England | British | 45765040001 | |||||
| REITER, Simon Philip | Geschäftsführer | Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House 15-19 England | United Kingdom | British | 135845570001 | |||||
| TAYLOR, Neil Robert | Geschäftsführer | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | 62846800003 | |||||
| WALFORD, Arthur David | Geschäftsführer | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 6658190001 | |||||
| ANS NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 1 Battersea Square SW11 3PZ London | 68699250001 | |||||||
| FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900013990001 |
Hat STEPHIGH LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 09. Jan. 2004 Geliefert am 14. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. März 2001 Geliefert am 11. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) whether for its own account or as trustee for the secured parties (as defined) or any of the other secured parties including any liability in respect of any further advances made under the facility (as defined) or the mezzanine loan facility (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Mai 1997 Geliefert am 20. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a eye hospital wilton avenue southamptom t/no HP422098 goodwill and proceeds of insurance thereon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 08. Mai 1997 Geliefert am 10. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben 1). f/h land and buildings k/a summerlands lodge nursing home 123 canterbury road westgage on sea keny t/no;-0K571115 2). f/h land and buildings k/a warrens hall nursing mhome 218 oakham road tividale warley west midlands t/no;-WM459415 3). f/h land k/a the site of the former eye hospital wilton avenue southampton t/no;-HP422098 any other property belonging or charged to the company during the contuance of this security all stocks shares and related rights all book and other debts goodwill and benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Mai 1997 Geliefert am 20. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 218 oakham road tividale warley west midlands t/no;-WM459415 goodwill andthe proceeds of insurance thereon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Mai 1997 Geliefert am 20. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a piper house 123 canterbury road westgate -on-sea t/no;-K571115 goodwill and the proceeds of insurance thereof. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Mai 1997 Geliefert am 14. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat STEPHIGH LTD Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0