TRENT FABRICATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTRENT FABRICATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03353085
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TRENT FABRICATIONS LIMITED?

    • Tätigkeit von Holdinggesellschaften für das Bauwesen (64203) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich TRENT FABRICATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Carlton Works
    Ossington Road Carlton On Trent
    NG23 6NT Newark
    Nottinghamshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TRENT FABRICATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CBS FABRICATIONS LIMITED04. März 201104. März 2011
    THE CALSAFE GROUP LIMITED08. Dez. 199708. Dez. 1997
    DIPLEMA 359 LIMITED15. Apr. 199715. Apr. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRENT FABRICATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für TRENT FABRICATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2020

    19 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019

    16 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 033530850010, erstellt am 09. Aug. 2019

    39 SeitenMR01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Richard Neil Paul als Direktor am 18. Feb. 2019

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 033530850008 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 033530850009 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Apr. 2017

    16 SeitenAA

    Notification of Michael Kaufman as a person with significant control on 20. Jan. 2017

    2 SeitenPSC01

    Cessation of Michael Kaufman as a person with significant control on 20. Jan. 2017

    1 SeitenPSC07

    Cessation of Mak Capital Fund Lp as a person with significant control on 20. Jan. 2017

    1 SeitenPSC07

    Change of details for Trent Topco Limited as a person with significant control on 18. Mai 2017

    2 SeitenPSC05

    Beendigung der Bestellung von Lee Craig Braithwaite als Geschäftsführer am 23. Okt. 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    8 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2016

    17 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 033530850008, erstellt am 14. Feb. 2017

    10 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 033530850009, erstellt am 14. Feb. 2017

    10 SeitenMR01

    Beendigung der Bestellung von Roger K Scholten als Sekretär am 20. Jan. 2017

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von TRENT FABRICATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LANG, James Paul
    Carlton Works
    Ossington Road Carlton On Trent
    NG23 6NT Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Carlton Works
    Ossington Road Carlton On Trent
    NG23 6NT Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish138282970001
    PAUL, Richard Neil
    Ossington Road
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NT Newark
    Carlton Works
    England
    Geschäftsführer
    Ossington Road
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NT Newark
    Carlton Works
    England
    EnglandBritish43099210003
    NUGENT, Jeffrey L
    Summerlin Court
    MI 48306 Rochester
    2609
    United States
    Sekretär
    Summerlin Court
    MI 48306 Rochester
    2609
    United States
    American129116160001
    SCHOLTEN, Roger K
    755 West Big Beaver Road,
    Suite 1000
    MI 48084 Troy
    Champion Homes Inc
    Michigan
    Usa
    Sekretär
    755 West Big Beaver Road,
    Suite 1000
    MI 48084 Troy
    Champion Homes Inc
    Michigan
    Usa
    American129116130001
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001
    WHEAT, Kevin Paul
    52 Park Lane
    Burton Waters
    LN1 2WP Lincoln
    Lincolnshire
    Sekretär
    52 Park Lane
    Burton Waters
    LN1 2WP Lincoln
    Lincolnshire
    British48248910002
    BRAITHWAITE, Lee Craig
    Carlton Works
    Ossington Road Carlton On Trent
    NG23 6NT Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Carlton Works
    Ossington Road Carlton On Trent
    NG23 6NT Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish128598360001
    COLLINS, John
    939 Yarmouth Road
    Bloomfield Hills
    Michigan Mi 48301
    Usa
    Geschäftsführer
    939 Yarmouth Road
    Bloomfield Hills
    Michigan Mi 48301
    Usa
    Usa110132610001
    DOWNEY, Gary Gerard
    Pheasants Walk
    YO61 2QS Helperby
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Pheasants Walk
    YO61 2QS Helperby
    Yorkshire
    British92121410001
    GRIFFITHS, William
    755 West Big Beaver Road,
    Suite 1000
    MI 48084 Troy
    Champion Homes Inc
    Michigan
    Usa
    Geschäftsführer
    755 West Big Beaver Road,
    Suite 1000
    MI 48084 Troy
    Champion Homes Inc
    Michigan
    Usa
    UsaUs Citizen112300370001
    HINTON, Philip Gordon
    Dukes Wharfe, The Norfolk 13 Dukes Wharfe
    Terry Avenue Clementhorpe
    YO23 1JE York
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    Dukes Wharfe, The Norfolk 13 Dukes Wharfe
    Terry Avenue Clementhorpe
    YO23 1JE York
    Yorkshire
    British97204070003
    HUTCHINSON, Gavin
    8 Ferriby High Road
    North Ferriby
    HU14 3LE Hull
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Ferriby High Road
    North Ferriby
    HU14 3LE Hull
    East Yorkshire
    British51083760008
    KNIGHT, Phyllis
    755 West Big Beaver Road
    Suite 1000
    MI 48084 Troy
    Champion Homes Inc
    Michigan
    Usa
    Geschäftsführer
    755 West Big Beaver Road
    Suite 1000
    MI 48084 Troy
    Champion Homes Inc
    Michigan
    Usa
    UsaAmerican112177800001
    REARDON, Jonathan Andrew
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Westfield Latchmore Bank
    Little Hallingbury
    CM22 7PH Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    British900005030001
    TURNBULL, David John
    Carlton Works, Ossington Road
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NT Newark
    Caledonian Building Systems Ltd
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Carlton Works, Ossington Road
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NT Newark
    Caledonian Building Systems Ltd
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish93985760002
    TYLER, Derrick
    Carlton Works
    Ossington Road Carlton On Trent
    NG23 6NT Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Carlton Works
    Ossington Road Carlton On Trent
    NG23 6NT Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish101205940003
    WEBSTER, Martin
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    10 St Peters Place
    W9 2EE London
    British900005040001
    WHEAT, Kevin Paul
    52 Park Lane
    Burton Waters
    LN1 2WP Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    52 Park Lane
    Burton Waters
    LN1 2WP Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritish48248910002
    WIGHTMAN, Stephen John
    Carlton Works
    Ossington Road Carlton On Trent
    NG23 6NT Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Carlton Works
    Ossington Road Carlton On Trent
    NG23 6NT Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish107573280001
    YOST, Mark Jason
    c/o Champion Home Builders, Inc.
    West Big Beaver Road
    Suite 1000
    Troy
    755
    Mi 48084
    Usa
    Geschäftsführer
    c/o Champion Home Builders, Inc.
    West Big Beaver Road
    Suite 1000
    Troy
    755
    Mi 48084
    Usa
    United StatesAmerican183522170001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TRENT FABRICATIONS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Michael Kaufman
    Madison Avenue
    24th Floor
    New York
    590
    Ny 10022
    Usa
    20. Jan. 2017
    Madison Avenue
    24th Floor
    New York
    590
    Ny 10022
    Usa
    Ja
    Nationalität: American
    Staatsangehörigkeit: Usa
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mak Capital Fund Lp
    31 Victoria Street
    Hamilton
    Victoria Place
    Hm10
    Bermuda
    20. Jan. 2017
    31 Victoria Street
    Hamilton
    Victoria Place
    Hm10
    Bermuda
    Ja
    RechtsformLimited Partnership
    RegistrierungslandBermuda
    RechtsgrundlageBermuda Monetary Authority
    RegistrierungsortBermuda Registrar Of Companies
    Registrierungsnummer34814
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Michael Kaufman
    Madison Avenue
    24th Floor
    10022 New York
    590
    New York
    United States
    20. Jan. 2017
    Madison Avenue
    24th Floor
    10022 New York
    590
    New York
    United States
    Nein
    Nationalität: American
    Staatsangehörigkeit: United States
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Caledonian Group Holdings Limited
    Ossington Road
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NT Newark
    Carlton Works
    England
    20. Jan. 2017
    Ossington Road
    Carlton-On-Trent
    NG23 6NT Newark
    Carlton Works
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer10477192
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat TRENT FABRICATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 09. Aug. 2019
    Geliefert am 09. Aug. 2019
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Aviva Insurance Limited
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 14. Feb. 2017
    Geliefert am 15. Feb. 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    1. by way of fixed charge (“the fixed charge”). (I) all freehold and leasehold land and buildings of the company both present and future including the land and buildings specified in section 2 of the schedule and all trade fixtures and fittings and all fixed plant and machinery from time to time in or on any such land and buildings;. (Ii) all patents, patent applications, trademarks, trade names, registered designs, copyrights, knowhow, and other intellectual property rights and all licences and ancillary rights and benefits (including royalties fees and other income deriving from the same ) now owned or at any time hereafter to be owned by the company.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nucleus Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 14. Feb. 2017
    Geliefert am 15. Feb. 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    1. by way of fixed charge (“the fixed charge”). (I) all freehold and leasehold land and buildings of the company both present and future including the land and buildings specified in section 2 of the schedule and all trade fixtures and fittings and all fixed plant and machinery from time to time in or on any such land and buildings;. (Ii) all patents, patent applications, trademarks, trade names, registered designs, copyrights, knowhow, and other intellectual property rights and all licences and ancillary rights and benefits (including royalties fees and other income deriving from the same ) now owned or at any time hereafter to be owned by the company.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Nucleus Property Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2009
    Geliefert am 10. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2003
    Geliefert am 18. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr Gavin Hutchinson
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2003
    Geliefert am 18. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr Philip Hinton
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2003
    Geliefert am 18. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr Kevin Wheat
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2003
    Geliefert am 11. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2003
    Geliefert am 08. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Aug. 1997
    Geliefert am 21. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0