WYNCON PUBLIC LIMITED COMPANY

WYNCON PUBLIC LIMITED COMPANY

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWYNCON PUBLIC LIMITED COMPANY
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 03360481
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WYNCON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    • (4521) /
    • (7011) /

    Wo befindet sich WYNCON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    10 Whitefriars
    Chester
    CH1 1NZ Cheshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WYNCON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WYNCON DEVELOPMENTS LIMITED10. Juni 199710. Juni 1997
    GRANGETREE LTD25. Apr. 199725. Apr. 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WYNCON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für WYNCON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006

    15 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2005

    16 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2004

    19 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    9 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2003

    19 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    8 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2002

    17 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von WYNCON PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REYNOLDS, Stephen William Michael
    Morar 20 Delavor Road
    CH60 4RW Heswall
    Wirral
    Sekretär
    Morar 20 Delavor Road
    CH60 4RW Heswall
    Wirral
    British95076900001
    JONES, Christopher Neville
    The Old Post Office
    The Street Slinfold
    RH13 0RP Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    The Old Post Office
    The Street Slinfold
    RH13 0RP Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish35333130004
    JONES, Michael Wyndham
    The Righi
    Rockey Lane Tattenhall
    CH3 9HJ Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Righi
    Rockey Lane Tattenhall
    CH3 9HJ Chester
    Cheshire
    British35333120003
    STOYLE, Laurence Kelvin Robert
    Dunnocks
    The Street
    RH20 3EP Thakeham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Dunnocks
    The Street
    RH20 3EP Thakeham
    West Sussex
    United KingdomBritish4856750004
    JONES, Christopher Neville
    Lockyers Farm
    Copsale
    RH13 6QR Horsham
    West Sussex
    Sekretär
    Lockyers Farm
    Copsale
    RH13 6QR Horsham
    West Sussex
    British35333130002
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Sekretär
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    JONES, Christopher Neville
    Lockyers Farm
    Copsale
    RH13 6QR Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Lockyers Farm
    Copsale
    RH13 6QR Horsham
    West Sussex
    British35333130002
    STOYLE, Laurence Kelvin Robert
    Dunnocks
    The Street
    RH20 3EP Thakeham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Dunnocks
    The Street
    RH20 3EP Thakeham
    West Sussex
    United KingdomBritish4856750004
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    Hat WYNCON PUBLIC LIMITED COMPANY Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. Dez. 2003
    Geliefert am 14. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land at martlets way worthing t/n WSX237886 and the f/h land and buildings known as the quadrant mercury court sealand road west chester t/n CH329318. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transaktionen
    • 14. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juli 2002
    Geliefert am 01. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    3,3A,4,4A,5,6,7,7A and 8 maidenbower village centre crwaley t/no WSX202932 assigns the rental income, the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all agreements for lease and all sums payable to the company under or in respect of any agreement for lease.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juli 2002
    Geliefert am 01. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that land and buildings on the south side of sealand road chester cheshire t/no CH329318 assigns the rental income, the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all agreements for lease and all sums payable to the company under or in respect of any agreement for lease.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 2002
    Geliefert am 01. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of receipts
    Erstellt am 30. Juli 1999
    Geliefert am 11. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any person who is a party to any related security documentation to the chargee under or pursuant to the terms of the loan agreement dated 27 july 1999 on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as the south side of brookers road billingshurst west sussex title number WSX176615 and the freehold property known as 49 station road billingshurst west sussex WSX141. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juli 1999
    Geliefert am 11. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a consumer credit agreement
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as the south side of brookes road billinghurst west sussex title number WSX176615 and the freehold property known 49 station road billinghurst west sussex title number WSX141.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juli 1999
    Geliefert am 11. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a consumer credit agreement
    Kurze Angaben
    The freehold land known as block g huffwood trading estate beillinghurst west sussex title number WSX153108.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Dez. 1998
    Geliefert am 15. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of receipts
    Erstellt am 04. Dez. 1998
    Geliefert am 11. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The rents reserved by the lease of the property k/a land and buildings on the north side of fyfield barrow and walnut tree milton keynes t/n BM202040 and land to the north and north west of fyfield barrow walnut tree milton keynes t/n BM233169.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 1998
    Geliefert am 11. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land and buildings on the north and south west side of fyfield barrow walnut tree milton keynes t/n BM218317.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 1998
    Geliefert am 11. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land lying to the north and north west of fyfield barrow walnut tree milton leynes t/n BM233169.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Dez. 1998
    Geliefert am 11. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings on the north side of fyfield barrow walnut tree milton keynes t/n BM202040.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WYNCON PUBLIC LIMITED COMPANY Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. Juni 2010Aufgelöst am
    08. Okt. 2007Antragsdatum
    26. Jan. 2010Abschluss der Liquidation
    30. Jan. 2008Beginn der Liquidation
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0