CLIFDEN DEVELOPMENTS LTD.
Überblick
Unternehmensname | CLIFDEN DEVELOPMENTS LTD. |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03364475 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CLIFDEN DEVELOPMENTS LTD.?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich CLIFDEN DEVELOPMENTS LTD.?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 22-24 Harborough Road Northampton NN2 7AZ Northants |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CLIFDEN DEVELOPMENTS LTD.?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SURVEYING AND CONTRACTING SERVICES LIMITED | 01. Mai 1997 | 01. Mai 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CLIFDEN DEVELOPMENTS LTD.?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CLIFDEN DEVELOPMENTS LTD.?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2021 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2020 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2019 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Neil Christopher Scott-Evans am 20. Juni 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Mr Neil Christopher Scott-Evans, as a person with significant control on 20. Juni 2016 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Notification of Douglas Knight as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Notification of Neil Christopher Scott-Evans, as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Neil Christopher Scott-Evans am 01. März 2016 | 4 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 20 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 18 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CLIFDEN DEVELOPMENTS LTD.?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOTT-EVANS, Neil Christopher | Geschäftsführer | Duston NN5 6NT Northampton 3 Quarry Road Northamptonshire England | England | British | Surveyor | 22546800005 | ||||
SCOTT-EVANS, Joan Marie | Sekretär | Ridgeway Weston Favell NN3 3AN Northampton 40 Northamptonshire | British | 20495380001 | ||||||
CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Temple House 20 Holywell Row EC2A 4JB London | 900000860001 | |||||||
KNIGHT, Douglas | Geschäftsführer | 10 Rose Avenue NN10 9NX Rushden Northamptonshire | United Kingdom | British | Builder | 22546810001 | ||||
WELCH, Ian | Geschäftsführer | 94 Church Way Weston Favell NN3 3BY Northampton | British | Procurement Consultant | 6246010002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CLIFDEN DEVELOPMENTS LTD.?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Neil Christopher Scott-Evans, | 06. Apr. 2016 | Kingsthorpe NN2 7AZ Northampton 22-24 Harborough Road United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mr Douglas Knight | 06. Apr. 2016 | Kingsthorpe NN2 7AZ Northampton 22-24 Harborough Road United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat CLIFDEN DEVELOPMENTS LTD. Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 16. Mai 2003 Geliefert am 20. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h k/a 31 and 33 rotton row rannos northampton t/n NN230038 and NN2303259. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Mai 2003 Geliefert am 29. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land to the rear of hillyards old road scaldwell northamptonshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Jan. 2002 Geliefert am 05. Feb. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plot 8 land on the east side of fairhaven 4 grove farm lane moulton daventry. T/n HN17932. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 16. Nov. 2001 Geliefert am 20. Nov. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h land previously k/a abbotts garage 45 west street earls barton northamptonshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. März 2000 Geliefert am 05. Apr. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 4 the grove moulton and land at the east side of 4 the grove moulton northamptonshire t/n NN209844 NN209845. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 21. Aug. 1998 Geliefert am 07. Sept. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at knights close earls barton northamptonshire t/n NN196396. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0