THE WHITE HORSE & GRIFFIN LIMITED

THE WHITE HORSE & GRIFFIN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE WHITE HORSE & GRIFFIN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03364498
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE WHITE HORSE & GRIFFIN LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
    • Lizensierte Restaurants (56101) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich THE WHITE HORSE & GRIFFIN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE WHITE HORSE & GRIFFIN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für THE WHITE HORSE & GRIFFIN LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE WHITE HORSE & GRIFFIN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    16 Seiten4.72

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    9 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    4 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * the White Horse & Griffin Church Street Whitby North Yorkshire YO21 4BW* am 14. März 2013

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Mai 2012

    Kapitalaufstellung am 22. Mai 2012

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2011

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2010

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs June Carolyn Perkins am 01. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Stewart Perkins am 01. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für June Carolyn Perkins am 01. Mai 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2009

    7 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2008

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    7 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von THE WHITE HORSE & GRIFFIN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PERKINS, June Carolyn
    Marstalls The Valley
    Sandsend
    YO21 3TE Whitby
    North Yorkshire
    Sekretär
    Marstalls The Valley
    Sandsend
    YO21 3TE Whitby
    North Yorkshire
    British91096070001
    PERKINS, June Carolyn
    Marstalls The Valley
    Sandsend
    YO21 3TE Whitby
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Marstalls The Valley
    Sandsend
    YO21 3TE Whitby
    North Yorkshire
    United KingdomBritish91096070001
    PERKINS, Stewart
    The Valley
    Sandsend
    YO21 3TE Whitby
    Marstalls
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Valley
    Sandsend
    YO21 3TE Whitby
    Marstalls
    North Yorkshire
    United KingdomBritish52928200002
    CLARKE, Brian Roger
    Flat 4 Crinkle Court
    9 Chubb Hill Road
    YO21 1JU Whitby
    North Yorkshire
    Sekretär
    Flat 4 Crinkle Court
    9 Chubb Hill Road
    YO21 1JU Whitby
    North Yorkshire
    British22127010001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    PERKINS, Margaret
    The White Horse And Griffin
    Church Street
    YO21 4BW Whitby
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The White Horse And Griffin
    Church Street
    YO21 4BW Whitby
    North Yorkshire
    British52928260001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat THE WHITE HORSE & GRIFFIN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Floating charge
    Erstellt am 24. Juli 2008
    Geliefert am 06. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold properties which are known as the white horse & griffin inn, church street, whitby t/n nyk 209487 and 3 foresters court, church street, whitby t/n nyk 190847 all the undertaking and assets all the uncalled capital in the floating charge see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Juli 2008
    Geliefert am 06. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as the white horse & griffin inn, church street, whitby, north yorkshire t/n nyk 209487 all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warrantees relating to the property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Juli 2008
    Geliefert am 06. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property known as 3 foresters court, church street, whitby, north yorkshire t/n nyk 190847 all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds, undertakings and warranties relating to the property. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Jan. 2002
    Geliefert am 01. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    3 foresters court, church street, whitby t/no. NYK190847. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Jan. 2002
    Geliefert am 01. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Warehouse behind the white horse & griffin inn, church street, whitby t/no. NYK68578. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Jan. 2002
    Geliefert am 01. Feb. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The white horse & griffin inn, church street, whitby t/no. NYK209487. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Jan. 2002
    Geliefert am 17. Jan. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 05. Apr. 2001
    Geliefert am 11. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Paul Andrew Whitwam and Gary Edgar Blackburn
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Sept. 1998
    Geliefert am 29. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    87 church street whitby north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Sept. 1998
    Geliefert am 25. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    3 foresters court whitby north yorkshire t/n-NYK190847.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Sept. 1998
    Geliefert am 25. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Warehouse behind the white horse & griffin 87 church street whitby north yorkshire-NYK68578.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 1998
    Geliefert am 25. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat THE WHITE HORSE & GRIFFIN LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Jan. 2001Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    07. März 2002Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Paul Andrew Whitwam
    30 Park Cross Street
    Leeds
    LS1 2QH
    Praktiker
    30 Park Cross Street
    Leeds
    LS1 2QH
    Gary E Blackburn
    30 Park Cross Street
    Leeds
    LS1 2QH
    Praktiker
    30 Park Cross Street
    Leeds
    LS1 2QH
    2
    DatumTyp
    27. März 2013Beginn der Liquidation
    11. Juli 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Julian Pitts
    Begbies Traynor Central Llp
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Begbies Traynor Central Llp
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    West Yorkshire
    David Frederick Wilson
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Praktiker
    Begbies Traynor
    9th Floor
    LS1 2JZ Bond Court
    Leeds
    Nicholas Edward Reed
    Begbies Traynor
    9th Floor, Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Begbies Traynor
    9th Floor, Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0