HSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED

HSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03364513
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich HSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CHARTERHOUSE PROPERTY LP LIMITED03. Okt. 199703. Okt. 1997
    262ND SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED01. Mai 199701. Mai 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für HSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Nov. 2017

    12 SeitenLIQ03

    Beendigung der Bestellung von Richard John Cole als Geschäftsführer am 06. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    10 SeitenLIQ10

    Beendigung der Bestellung von Michael Connelly Anderson als Geschäftsführer am 22. März 2017

    1 SeitenTM01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 8 Canada Square London E14 5HQ verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 8 Canada Square London E14 5HQ geändert

    2 SeitenAD02

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 8 Canada Square London E14 5HQ zum Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR am 28. Nov. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Nov. 2016

    LRESSP

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 04. Mai 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Mr Michael Connelly Anderson als Direktor am 19. Jan. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David John Cavanna als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    18 SeitenAA

    Ernennung von Ms Romana Lewis als Sekretär am 13. Aug. 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 13. Aug. 2015

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 11. Mai 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 05. Jan. 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Tony Bhambhra als Sekretär am 05. Jan. 2015

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    18 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von HSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Sekretär
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    200248620001
    MARLOW, Jonathan Peter
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish159417990001
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    186747190001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    177225330001
    JENKINSON, Louisa Jane
    Lindenwood
    Malacca Farm
    GU4 7UG West Clandon
    Surrey
    Sekretär
    Lindenwood
    Malacca Farm
    GU4 7UG West Clandon
    Surrey
    British106060330003
    LYON, Karen
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    161199650001
    MILLER, Philip
    Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    87
    Sekretär
    Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    87
    Other128209650001
    OWEN, Stephen
    Clayton Croft Road
    Wilmington
    DA2 7AU Kent
    11
    United Kingdom
    Sekretär
    Clayton Croft Road
    Wilmington
    DA2 7AU Kent
    11
    United Kingdom
    Other132334270001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194217980001
    PATERNOSTER SECRETARIES LIMITED
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    Sekretär
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    76827740002
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Sekretär
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Geschäftsführer
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    COLE, Richard John
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish32663530001
    DE ALBUQUERQUE, Simon Peter
    15 Fielding Mews
    Barnes
    SW13 9EY London
    Geschäftsführer
    15 Fielding Mews
    Barnes
    SW13 9EY London
    EnglandBritish150525130001
    GLOVER, Edward Douglas
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish121380002
    HUXTABLE, Christopher John
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish156351910001
    MACKEY, Paul Emmanuel
    59 Geffers Ride
    Burley Wood
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    Geschäftsführer
    59 Geffers Ride
    Burley Wood
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    Irish11264820004
    THORP, Timothy Geoffrey
    3 St George's Road
    TN13 3ND Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    3 St George's Road
    TN13 3ND Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish66923730003
    VON GUIONNEAU, Werner Marc Friedrich
    33 Lansdowne Road
    W11 2LQ London
    Geschäftsführer
    33 Lansdowne Road
    W11 2LQ London
    EnglandGerman,110089200001
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001760001
    SERJEANTS' INN NOMINEES LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001750001

    Hat HSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental debenture
    Erstellt am 06. Dez. 2002
    Geliefert am 13. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors and the nominee to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h land being land adjoining aberafan shopping centre port talbot and being part of t/n WA102769 and t/n WA172801 and all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft, as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 16. Okt. 2002
    Geliefert am 22. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors and the nominee to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The benefit of the deed of settlement and the right to recover and receive all compensation which may be payable to it in respect of the deed of settlement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft as Agent
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 25. Apr. 2002
    Geliefert am 01. Mai 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the obligors and each nominee to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including (I) 201 albion road,london N16 9JU,hackney; t/no 146405; (ii) allport mews,tower hamlets,london E1; LN57642,LN59206 and LN64640; (iii) 18 aristotle road,lambeth,london SW4 7UZ; LN233901 plus various other properties listed; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft,as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 01. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2001
    Geliefert am 18. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilites actual or contingent whether owed jointly or severally or in any capacity whatsoever of the obligors and the nominees to each finance party under each finance document
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wurttemburgische Hypothekenbank Aktiengesellschaft (As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 07. Sept. 2001
    Geliefert am 14. Sept. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the obligors (as defined) and the nominee to the chargee (the "agent) as agent and trustee for the finance parties (as defined in the credit agreement) under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    All rights of the company as general partner carrying on business under the name of the charterhouse shopping centre fund under any hedging arrangement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 11. Juli 2001
    Geliefert am 25. Juli 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the obligors and the nominee to each finance party under each finance document (each defined therein)
    Kurze Angaben
    The f/h land adjoining aberafan shopping centre port talbot t/n wa 172801 and part of WA102769 together with a first fixed charge all its rights under each development document and has assigned absolutely to the agent by way of security all its rights under each development document. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaftas Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Juni 2001
    Geliefert am 25. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the obligors and the nominee to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    The rihw shipping centre, bridgend, nolton arcade and 12-26 (even) nolton street, bridgend and 24 and 26 caroline street, bridgend as the same is registered under t/n WA416494, WA678309, WA68105, WA277301 and WA25880. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee Forthe Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Juni 2001
    Geliefert am 25. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the obligors and the nominee to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    The quedam centre, 29-29A middle street, yeovil and 6 frederick place and 35 middle street yeovil together with the columns, staircases and airspace over the service yards at glovers walk, yeovil t/ns ST95800, WS1046, ST137380 and ST92261. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee Forthe Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Juni 2001
    Geliefert am 25. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the obligors and the nominee to each finance party under each finance document (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    Union shopping centre and 75, 83-85 union street, torquay devon t/n DN116816, DN98678, DN277469 and DN365665. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee Forthe Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Feb. 2001
    Geliefert am 01. März 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointley or severally or in any other capacity whatsoever of the obligors and the nominee to each fiance party under each finance document (all terms defined therein)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 01. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors and/or the nominee to each finance party under each finance document (all defined therein)
    Erstellt am 17. März 2000
    Geliefert am 06. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors and/or the nominee to each finance party under each finance document (all defined therein)
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a the aberafan shopping centre port talbot wales t/n WA769757 and l/h land and buildings k/a market hall aberafan shopping centre port talbot wales t/NWA896167 by way of first fixed charge all plant and machinery, all moneys and the debts, all benefits of insurances, licences, its right under any hedging arrangements and any agreement relating to the purchase of the property by the chargors. By way of assignment all rental income, security all the rights under any insurance. By way of floating charge all its assets other than those assets otherwise effectively mortgaged or charged by way of fixed mortgage or charge.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 1999
    Geliefert am 25. Aug. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors and/or the nominee to each finance party under each finance document (all defined therein)
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a kingsland shopping centre (previously k/a the former british rail goods yard, dalston and 64 and 66 kingsland high street) t/nos egl 188313 & egl 237456.by way of first fixed charge all plant and machinery, all moneys and the debts, all benefits of insurances, licences, its right under any hedging arrangements and any agreement relating to the purchase of the property by the chargors. By way of assignment all rental income, security all the rights under any insurance. By way of floating charge all its assets other than those assets otherwise effectively mortgaged or charged by way of fixed mortgage or charge.
    Berechtigte Personen
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 25. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)

    Hat HSBC PROPERTY FUNDS INVESTMENT LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Nov. 2016Beginn der Liquidation
    20. Okt. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praktiker
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Ian Harvey Dean
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0