CALLCENTRIC LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCALLCENTRIC LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03367572
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CALLCENTRIC LIMITED?

    • Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich CALLCENTRIC LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CALLCENTRIC LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für CALLCENTRIC LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Brent Austin Marshall als Geschäftsführer am 13. Sept. 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von James Kent als Geschäftsführer am 13. Sept. 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Brent Austin Marshall als Sekretär am 13. Sept. 2013

    1 SeitenTM02

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG United Kingdom geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Mai 2013

    Kapitalaufstellung am 10. Mai 2013

    • Kapital: GBP 82,052.14
    SH01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012

    8 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr James Kent am 01. Nov. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Brent Austin Marshall als Sekretär am 19. März 2012

    1 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Brent Austin Marshall als Direktor am 19. März 2012

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011

    2 SeitenAA

    Ernennung von Mr Jon Andrew Victor Sopher als Direktor am 14. Dez. 2011

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Richard Alan Wingfield als Geschäftsführer am 04. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CALLCENTRIC LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SOPHER, Jon Andrew Victor
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    Geschäftsführer
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    United KingdomBritish58720360003
    ALLY, Bibi Rahima
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    Sekretär
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    British38963210007
    HARRIS, Philip Bernard
    85 Western Road
    Ealing
    W5 5DT London
    Sekretär
    85 Western Road
    Ealing
    W5 5DT London
    British54037970002
    LEWIS, Paul Raymond Thomas
    11 Wellfield Gardens
    SM5 4EA Carshalton Beeches
    Surrey
    Sekretär
    11 Wellfield Gardens
    SM5 4EA Carshalton Beeches
    Surrey
    British147923250001
    MARSHALL, Brent Austin
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    Sekretär
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    167691820001
    WINGFIELD, Richard Alan
    Town Farm Close
    OX9 2DA Thame
    1
    Oxfordshire
    Sekretär
    Town Farm Close
    OX9 2DA Thame
    1
    Oxfordshire
    149795610001
    BANNER & ASSOCIATES LTD
    29 Byron Road
    HA1 1JR Harrow
    Middlesex
    Bevollmächtigter Sekretär
    29 Byron Road
    HA1 1JR Harrow
    Middlesex
    900011090001
    BEYNSBERGER, David
    6 Coombe Hill Court
    SL4 4UL Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    6 Coombe Hill Court
    SL4 4UL Windsor
    Berkshire
    British52160540001
    CLARK, Robert Ian
    25 Carpenders Close
    AL5 3HN Harpenden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    25 Carpenders Close
    AL5 3HN Harpenden
    Hertfordshire
    British78415290002
    FAUX, Sarah
    3 Glenmore House
    Richmond Hill
    TW10 6BQ Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 Glenmore House
    Richmond Hill
    TW10 6BQ Richmond
    Surrey
    British84672680001
    HARRIS, Philip Bernard
    85 Western Road
    Ealing
    W5 5DT London
    Geschäftsführer
    85 Western Road
    Ealing
    W5 5DT London
    United KingdomBritish54037970002
    KENT, James
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    Geschäftsführer
    1000 Great West Road
    Brentford
    TW8 9HH Middlesex
    United KingdomBritish148367460001
    LANGMORE, Michael
    28 Russell Road
    HA6 2LR Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    28 Russell Road
    HA6 2LR Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish11172280001
    LEWIS, Paul Raymond Thomas
    11 Wellfield Gardens
    SM5 4EA Carshalton Beeches
    Surrey
    Geschäftsführer
    11 Wellfield Gardens
    SM5 4EA Carshalton Beeches
    Surrey
    United KingdomBritish147923250001
    MARSHALL, Brent Austin
    Southdowns
    The Avenue Clifton
    BS8 3GE Bristol
    Flat 7
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Southdowns
    The Avenue Clifton
    BS8 3GE Bristol
    Flat 7
    United Kingdom
    EnglandBritish167689850001
    OLISA, Kenneth Aphunezi, Sir
    18 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    18 Glamorgan Road
    Hampton Wick
    KT1 4HP Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish31705700001
    PARKER, Nicholas
    Crome Hill
    Ashridge Park
    HP4 1NP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Crome Hill
    Ashridge Park
    HP4 1NP Berkhamsted
    Hertfordshire
    British70897450001
    PORTLOCK, Michael Kenneth
    Skimbleshanks
    Hook Heath Road
    GU22 0LE Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Skimbleshanks
    Hook Heath Road
    GU22 0LE Woking
    Surrey
    British63903230001
    RANSOM, Graham Richard
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    8 Fairacre
    Woolton Hill
    RG20 9UF Newbury
    Berkshire
    UkBritish34690210001
    ROGERS, Derek
    42 Belvedere Road
    SE19 2HW London
    Geschäftsführer
    42 Belvedere Road
    SE19 2HW London
    EnglandBritish73548000001
    TAILOR, Pravin
    Chess Way
    Chorley Wood
    WD3 5TA Rickmansworth
    Fairwinds
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Chess Way
    Chorley Wood
    WD3 5TA Rickmansworth
    Fairwinds
    Hertfordshire
    United KingdomBritish23960250003
    VITHALDAS, Vim
    6 The Chase
    Great Amwell
    SG12 9TN Ware
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 The Chase
    Great Amwell
    SG12 9TN Ware
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59433340003
    WINGFIELD, Richard Alan
    Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    1
    Oxon
    Geschäftsführer
    Town Farm Close
    Thame
    OX9 2DA Oxford
    1
    Oxon
    EnglandBritish76932830002
    BANNER NOMINEES LTD
    29 Byron Road
    HA1 1JR Harrow
    Middlesex
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    29 Byron Road
    HA1 1JR Harrow
    Middlesex
    900011080001

    Hat CALLCENTRIC LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A deed of admission
    Erstellt am 09. März 2007
    Geliefert am 19. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The credit balance being any sum standing to the credit of an account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Omnibus guarantee & set off agreement
    Erstellt am 02. März 2007
    Geliefert am 12. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company charges under the agreement its credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 02. März 2007
    Geliefert am 12. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 08. März 2004
    Geliefert am 15. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more companies including any accounts in the banks name with any designation which includes the names of the companies or any one or more of the companies. (The accounts). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 06. Jan. 2003
    Geliefert am 17. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any one or more of the companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more companies including any accounts in the bank name with any designation which includes the name of the companies or any one or more of the companies.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Sept. 2002
    Geliefert am 25. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any principal debtor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Point-on Holdings Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 26. Nov. 1998
    Geliefert am 01. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 18. Juli 1997
    Geliefert am 23. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 23. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0