CALLCENTRIC LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CALLCENTRIC LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03367572 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CALLCENTRIC LIMITED?
- Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich CALLCENTRIC LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1000 Great West Road Brentford TW8 9HH Middlesex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CALLCENTRIC LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CALLCENTRIC LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brent Austin Marshall als Geschäftsführer am 13. Sept. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Kent als Geschäftsführer am 13. Sept. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brent Austin Marshall als Sekretär am 13. Sept. 2013 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 2 Temple Back East Temple Quay Bristol BS1 6EG United Kingdom geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Kent am 01. Nov. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Brent Austin Marshall als Sekretär am 19. März 2012 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Brent Austin Marshall als Direktor am 19. März 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Jon Andrew Victor Sopher als Direktor am 14. Dez. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Alan Wingfield als Geschäftsführer am 04. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CALLCENTRIC LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPHER, Jon Andrew Victor | Geschäftsführer | 1000 Great West Road Brentford TW8 9HH Middlesex | United Kingdom | British | 58720360003 | |||||
| ALLY, Bibi Rahima | Sekretär | Norwich Street EC4A 1BD London 10 | British | 38963210007 | ||||||
| HARRIS, Philip Bernard | Sekretär | 85 Western Road Ealing W5 5DT London | British | 54037970002 | ||||||
| LEWIS, Paul Raymond Thomas | Sekretär | 11 Wellfield Gardens SM5 4EA Carshalton Beeches Surrey | British | 147923250001 | ||||||
| MARSHALL, Brent Austin | Sekretär | 1000 Great West Road Brentford TW8 9HH Middlesex | 167691820001 | |||||||
| WINGFIELD, Richard Alan | Sekretär | Town Farm Close OX9 2DA Thame 1 Oxfordshire | 149795610001 | |||||||
| BANNER & ASSOCIATES LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 29 Byron Road HA1 1JR Harrow Middlesex | 900011090001 | |||||||
| BEYNSBERGER, David | Geschäftsführer | 6 Coombe Hill Court SL4 4UL Windsor Berkshire | British | 52160540001 | ||||||
| CLARK, Robert Ian | Geschäftsführer | 25 Carpenders Close AL5 3HN Harpenden Hertfordshire | British | 78415290002 | ||||||
| FAUX, Sarah | Geschäftsführer | 3 Glenmore House Richmond Hill TW10 6BQ Richmond Surrey | British | 84672680001 | ||||||
| HARRIS, Philip Bernard | Geschäftsführer | 85 Western Road Ealing W5 5DT London | United Kingdom | British | 54037970002 | |||||
| KENT, James | Geschäftsführer | 1000 Great West Road Brentford TW8 9HH Middlesex | United Kingdom | British | 148367460001 | |||||
| LANGMORE, Michael | Geschäftsführer | 28 Russell Road HA6 2LR Northwood Middlesex | England | British | 11172280001 | |||||
| LEWIS, Paul Raymond Thomas | Geschäftsführer | 11 Wellfield Gardens SM5 4EA Carshalton Beeches Surrey | United Kingdom | British | 147923250001 | |||||
| MARSHALL, Brent Austin | Geschäftsführer | Southdowns The Avenue Clifton BS8 3GE Bristol Flat 7 United Kingdom | England | British | 167689850001 | |||||
| OLISA, Kenneth Aphunezi, Sir | Geschäftsführer | 18 Glamorgan Road Hampton Wick KT1 4HP Kingston Upon Thames Surrey | England | British | 31705700001 | |||||
| PARKER, Nicholas | Geschäftsführer | Crome Hill Ashridge Park HP4 1NP Berkhamsted Hertfordshire | British | 70897450001 | ||||||
| PORTLOCK, Michael Kenneth | Geschäftsführer | Skimbleshanks Hook Heath Road GU22 0LE Woking Surrey | British | 63903230001 | ||||||
| RANSOM, Graham Richard | Geschäftsführer | 8 Fairacre Woolton Hill RG20 9UF Newbury Berkshire | Uk | British | 34690210001 | |||||
| ROGERS, Derek | Geschäftsführer | 42 Belvedere Road SE19 2HW London | England | British | 73548000001 | |||||
| TAILOR, Pravin | Geschäftsführer | Chess Way Chorley Wood WD3 5TA Rickmansworth Fairwinds Hertfordshire | United Kingdom | British | 23960250003 | |||||
| VITHALDAS, Vim | Geschäftsführer | 6 The Chase Great Amwell SG12 9TN Ware Hertfordshire | United Kingdom | British | 59433340003 | |||||
| WINGFIELD, Richard Alan | Geschäftsführer | Town Farm Close Thame OX9 2DA Oxford 1 Oxon | England | British | 76932830002 | |||||
| BANNER NOMINEES LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 29 Byron Road HA1 1JR Harrow Middlesex | 900011080001 |
Hat CALLCENTRIC LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A deed of admission | Erstellt am 09. März 2007 Geliefert am 19. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The credit balance being any sum standing to the credit of an account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Omnibus guarantee & set off agreement | Erstellt am 02. März 2007 Geliefert am 12. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company charges under the agreement its credit balances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. März 2007 Geliefert am 12. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 08. März 2004 Geliefert am 15. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more companies including any accounts in the banks name with any designation which includes the names of the companies or any one or more of the companies. (The accounts). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 06. Jan. 2003 Geliefert am 17. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any one or more of the companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more companies including any accounts in the bank name with any designation which includes the name of the companies or any one or more of the companies.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 05. Sept. 2002 Geliefert am 25. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any principal debtor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Nov. 1998 Geliefert am 01. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Juli 1997 Geliefert am 23. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0