M3 CONSULTANTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | M3 CONSULTANTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03368976 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von M3 CONSULTANTS LIMITED?
- (7450) /
Wo befindet sich M3 CONSULTANTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Rdl House 1 Chertsey Road GU21 5AD Woking Surrey |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von M3 CONSULTANTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| M3 GROUP PLC | 12. Mai 1997 | 12. Mai 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von M3 CONSULTANTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für M3 CONSULTANTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stuart Glynn Britton als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Suzanne Ostrowski als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2002 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von M3 CONSULTANTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARDNER, James Nigel | Sekretär | 28 Oxted Green Milford GU8 5DE Godalming Surrey | British | 8348600002 | ||||||
| BRITTON, Stuart Glynn | Geschäftsführer | Rdl House 1 Chertsey Road GU21 5AD Woking Surrey | United Kingdom | British | 95407210002 | |||||
| GARDNER, James Nigel | Geschäftsführer | 28 Oxted Green Milford GU8 5DE Godalming Surrey | England | British | 8348600002 | |||||
| CHARMAN, Mark Victor | Sekretär | Little Bowyer Cottage 1 Gravesend Road TN15 7QD Wrotham Hill Kent | British | 45883280003 | ||||||
| SIMS, Helen Margaret | Sekretär | Hook Heath Road GU22 0QE Woking Coign Surrey | British | 58817110002 | ||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||
| BAKER, Michael | Geschäftsführer | Sturgeons Farm Midle Green Wakes Colne CO6 2BN Colchester Essex | British | 93708800001 | ||||||
| CHARMAN, Mark Victor | Geschäftsführer | Little Bowyer Cottage 1 Gravesend Road TN15 7QD Wrotham Hill Kent | British | 45883280003 | ||||||
| LARDNER, Bernard John | Geschäftsführer | Werfa East Road KT13 0LF Weybridge Surrey | British | 1926410001 | ||||||
| LEE, Alistair James | Geschäftsführer | Hog Hole Lane TN3 8BN Lamberhurst Maitlands Kent | United Kingdom | British | 129705590001 | |||||
| OSTROWSKI, Suzanne Jane | Geschäftsführer | Weybury 8 Great Quarry GU1 3XN Guildford Surrey | United Kingdom | British | 26162970007 | |||||
| RICHARDS, Andrew | Geschäftsführer | West Court Fishery Road SL6 1UN Bray Berkshire | British | 6808500004 | ||||||
| SIMS, Helen Margaret | Geschäftsführer | Hook Heath Road GU22 0QE Woking Coign Surrey | England | British | 58817110002 | |||||
| ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004520001 | |||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 11 Beaumont Gate Shenley Hill WD7 7AR Radlett Hertfordshire | 62720590003 |
Hat M3 CONSULTANTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture between the company (the chargor) and other (as charging companies) (1) and barclays bank PLC (as "bank") (2) | Erstellt am 29. Sept. 2000 Geliefert am 05. Okt. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All money and liabilities due owing or incurred to the chargee by the chargor and by each other company (except as guarantor for the chargor) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Juni 1998 Geliefert am 17. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 23. März 1998 Geliefert am 06. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0