ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03370146
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    33 Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TRANSWORLD HEALTHCARE (UK) LIMITED27. Mai 199727. Mai 1997
    PURELUCKY LIMITED14. Mai 199714. Mai 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    15 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Carl Michael Brown als Geschäftsführer am 29. Nov. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Collison als Sekretär am 29. Nov. 2018

    1 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Cavendish House Lakhpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX England zum 33 Glasshouse Street London W1B 5DG am 02. Dez. 2018

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Joanne Machin als Geschäftsführer am 01. Nov. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Luca Warnke als Geschäftsführer am 01. Nov. 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    17 SeitenAA

    Ernennung von Dr Caspaar Friedrich Trautwein als Direktor am 03. Aug. 2018

    2 SeitenAP01

    Kapitalaufstellung am 06. Juli 2018

    • Kapital: GBP 100
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reduce share prem a/c 25/06/2018
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Miss Joanne Machin als Direktor am 01. Aug. 2017

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von John Henry Whitehead als Geschäftsführer am 12. Juni 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Carl Michael Brown als Direktor am 12. Juni 2017

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    16 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von David Collison als Geschäftsführer am 31. Jan. 2017

    1 SeitenTM01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Wer sind die Geschäftsführer von ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TRAUTWEIN, Caspaar Friedrich, Dr
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    Geschäftsführer
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    GermanyGerman249111890001
    COLLISON, David
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    Sekretär
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    204256890001
    DAVIES, John
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    Sekretär
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    166608020001
    HAYNES, Victoria
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Sekretär
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    British182412280001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Sekretär
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Sekretär
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    PALLADINO, Wayne A
    25 Mereland Road
    NEW YORK New Rochelle
    10804
    Sekretär
    25 Mereland Road
    NEW YORK New Rochelle
    10804
    Usa64401390001
    PALLADINO, Wayne A
    25 Mereland Road
    NEW YORK New Rochelle
    10804
    Sekretär
    25 Mereland Road
    NEW YORK New Rochelle
    10804
    Usa64401390001
    STRINGER, Andrew Paul
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Sekretär
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    171546320001
    WADDELL, Ian Francis
    Muirside Glebe Lane
    Hartley Wintney
    RG27 8EA Basingstoke
    Hampshire
    Sekretär
    Muirside Glebe Lane
    Hartley Wintney
    RG27 8EA Basingstoke
    Hampshire
    British28497990001
    WESTWOOD, Philip John
    Allied Healthcare Group Limited
    Stone Business Park Brooms Road
    ST15 0TL Stone
    Staffordshire
    Sekretär
    Allied Healthcare Group Limited
    Stone Business Park Brooms Road
    ST15 0TL Stone
    Staffordshire
    British71727490001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AITKEN, Timothy Maxwell
    870 Fifth Avenue Apt 14e
    NY 10021 New York
    Usa
    Geschäftsführer
    870 Fifth Avenue Apt 14e
    NY 10021 New York
    Usa
    British65840370004
    BATEMAN, Stephen John
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish133761180001
    BROWN, Carl Michael
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    Geschäftsführer
    Glasshouse Street
    W1B 5DG London
    33
    England
    EnglandBritish232841280001
    COLLISON, David
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Geschäftsführer
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    United KingdomBritish34835160001
    EAMES, Sarah Ladd
    Flat F 34 Cadogan Square
    SW1X 0JL London
    Geschäftsführer
    Flat F 34 Cadogan Square
    SW1X 0JL London
    American75443640001
    EAMES, Sarah L
    5 Westwoodcourt
    NEW YORK Harrison
    10528
    Usa
    Geschäftsführer
    5 Westwoodcourt
    NEW YORK Harrison
    10528
    Usa
    Usa64401310001
    ELLIS, Martyn Anthony
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish95749550002
    FINE, Robert
    111 Ashley Avenue
    Brielle
    New Jersey
    08730
    Usa
    Geschäftsführer
    111 Ashley Avenue
    Brielle
    New Jersey
    08730
    Usa
    American54235090001
    FISHER, Amanda Lucia
    The Rowans
    Merretts Orchard
    GL2 7DS Sumbridge
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    The Rowans
    Merretts Orchard
    GL2 7DS Sumbridge
    Gloucestershire
    EnglandBritish174485990001
    GIBSON, Darryn Stanley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomNew Zealander177930490001
    GREEN, George Richard
    Selhurst Park House,
    Selhurst Park, Halnaker
    PO18 0LZ Chichester
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Selhurst Park House,
    Selhurst Park, Halnaker
    PO18 0LZ Chichester
    West Sussex
    EnglandBritish4795650003
    GREEN, George Richard
    Selhurst Park House,
    Selhurst Park, Halnaker
    PO18 0LZ Chichester
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Selhurst Park House,
    Selhurst Park, Halnaker
    PO18 0LZ Chichester
    West Sussex
    EnglandBritish4795650003
    HOWARD, Stuart Michael
    c/o Saga Healthcare
    Enbrook Park
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    c/o Saga Healthcare
    Enbrook Park
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    England
    United KingdomBritish160271430001
    IVERS, John Joseph
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    c/o Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish77692980002
    JOHNSON, David Ian
    6 Mill Farm Court
    Chebsey
    ST21 6HZ Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    6 Mill Farm Court
    Chebsey
    ST21 6HZ Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish46008570001
    KERNAHAN, Charles Lloyd
    The Old Barn Main Street
    Sutton On Trent
    NG23 6PF Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Old Barn Main Street
    Sutton On Trent
    NG23 6PF Newark
    Nottinghamshire
    British50116330001
    LAVERY, Daniel Mark
    23 Cornwall House
    Portland Crescent
    HG1 2TR Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    23 Cornwall House
    Portland Crescent
    HG1 2TR Harrogate
    North Yorkshire
    British111619010001
    MACHIN, Joanne
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Geschäftsführer
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    EnglandBritish236304960001
    MASON, Catherine Lois
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Geschäftsführer
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    EnglandBritish224233880001
    MOFFATT, David Stewart
    2 Lawrence Gardens
    Mill Hill
    NW7 4JT London
    Geschäftsführer
    2 Lawrence Gardens
    Mill Hill
    NW7 4JT London
    EnglandBritish88747420001
    MOSELEY, Frederick
    173 Larch Row
    Wenham
    Massachussetts Ma 01984
    Usa
    Geschäftsführer
    173 Larch Row
    Wenham
    Massachussetts Ma 01984
    Usa
    American67910480001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Geschäftsführer
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Geschäftsführer
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    British69603410001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Allied Healthcare Group Holdings Limited
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    06. Apr. 2016
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House England And Wales
    Registrierungsnummer3890177
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Floating security document
    Erstellt am 19. Juli 2004
    Geliefert am 28. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 28. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash collateral account
    Erstellt am 22. Jan. 2003
    Geliefert am 06. Feb. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the cash collateral account and the charged balance where the account is the interest bearing sterling deposit account opened maintained and held by the chargee with account number 50451347 sort code 20-77-67 and designated barclays bank re staffing enterprise loan note account which includes any sub-account re-designation or substitution of said account. The charged balance means all monies standing to the credit of the cash collateral account with all interest accruing therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over collateral account
    Erstellt am 15. Okt. 2002
    Geliefert am 28. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in the cash collateral account being the interest bearing sterling deposit account opened maintained and held by the chargee with account number 80358355 sort code 20-77-67 and designated barclays bank re j s bal loan note account and includes any sub-account any redesignation of that account and any account substituted as the cash collateral account by written agreement between the parties, and the charged balance being all monies from time to time standing to the credit of the cash collateral account together with the interest accruing thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over cash collateral account
    Erstellt am 30. Juli 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The cash collateral account and the charged balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A charge over earn out account and acquisition expenditure account made by the company in favour of barclays bank PLC as security agent for and on behalf of the beneficiaries set out in the intercreditor deed (the "security agent")
    Erstellt am 27. Sept. 2001
    Geliefert am 05. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations owing to the beneficiaries or to the security agent (whether for its own account or on behalf of the beneficiaries) by the obligors under or pursuant to the finance documents (including the debenture) whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or surety or in some other capacity)
    Kurze Angaben
    Each credit balance from time to time on the earn out account number 20421677 sort code 20-77-67 and on the acquisition expenditure account number 30776576.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A charge over cash collateral account
    Erstellt am 27. Sept. 2001
    Geliefert am 05. Okt. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan note guarantee facility
    Kurze Angaben
    All monies from time to time standing to the credit of the sterling deposit account number 20478776 sort code 20-77-67 with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over cash collateral account
    Erstellt am 02. Aug. 2001
    Geliefert am 09. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the loan note guarantee facility of even date
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in the cash collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash collateral account
    Erstellt am 15. Juni 2001
    Geliefert am 27. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee (the guarantee bank) under the loan note guarantee facility (as defined)
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all its right title and interest in all monies from time to time standing to the credit of the cash collateral account - account no.90076120. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Dez. 1999
    Geliefert am 23. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations of transworld healthcare (UK) limited (the obligor) to the chargee as agent and security agent for and on behalf of the beneficiaries on the terms and conditions set out in the intercreditor deed under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Dez. 1999
    Geliefert am 23. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations of transworld healthcare (UK) limited (the obligor) to the chargee as agent and security agent for and on behalf of the beneficiaries on the terms and conditions set out in the intercreditor deed under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0