ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03370146 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 33 Glasshouse Street W1B 5DG London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TRANSWORLD HEALTHCARE (UK) LIMITED | 27. Mai 1997 | 27. Mai 1997 |
| PURELUCKY LIMITED | 14. Mai 1997 | 14. Mai 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Carl Michael Brown als Geschäftsführer am 29. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Collison als Sekretär am 29. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cavendish House Lakhpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX England zum 33 Glasshouse Street London W1B 5DG am 02. Dez. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanne Machin als Geschäftsführer am 01. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Luca Warnke als Geschäftsführer am 01. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Dr Caspaar Friedrich Trautwein als Direktor am 03. Aug. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 06. Juli 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Miss Joanne Machin als Direktor am 01. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Henry Whitehead als Geschäftsführer am 12. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Carl Michael Brown als Direktor am 12. Juni 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Collison als Geschäftsführer am 31. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAUTWEIN, Caspaar Friedrich, Dr | Geschäftsführer | Glasshouse Street W1B 5DG London 33 England | Germany | German | 249111890001 | |||||
| COLLISON, David | Sekretär | Glasshouse Street W1B 5DG London 33 England | 204256890001 | |||||||
| DAVIES, John | Sekretär | Enbrook Park Sandgate High Street Sandgate CT20 3SE Folkestone 2 Kent United Kingdom | 166608020001 | |||||||
| HAYNES, Victoria | Sekretär | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 182412280001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Sekretär | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Sekretär | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
| PALLADINO, Wayne A | Sekretär | 25 Mereland Road NEW YORK New Rochelle 10804 | Usa | 64401390001 | ||||||
| PALLADINO, Wayne A | Sekretär | 25 Mereland Road NEW YORK New Rochelle 10804 | Usa | 64401390001 | ||||||
| STRINGER, Andrew Paul | Sekretär | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | 171546320001 | |||||||
| WADDELL, Ian Francis | Sekretär | Muirside Glebe Lane Hartley Wintney RG27 8EA Basingstoke Hampshire | British | 28497990001 | ||||||
| WESTWOOD, Philip John | Sekretär | Allied Healthcare Group Limited Stone Business Park Brooms Road ST15 0TL Stone Staffordshire | British | 71727490001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| AITKEN, Timothy Maxwell | Geschäftsführer | 870 Fifth Avenue Apt 14e NY 10021 New York Usa | British | 65840370004 | ||||||
| BATEMAN, Stephen John | Geschäftsführer | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | England | British | 133761180001 | |||||
| BROWN, Carl Michael | Geschäftsführer | Glasshouse Street W1B 5DG London 33 England | England | British | 232841280001 | |||||
| COLLISON, David | Geschäftsführer | Lakhpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House England | United Kingdom | British | 34835160001 | |||||
| EAMES, Sarah Ladd | Geschäftsführer | Flat F 34 Cadogan Square SW1X 0JL London | American | 75443640001 | ||||||
| EAMES, Sarah L | Geschäftsführer | 5 Westwoodcourt NEW YORK Harrison 10528 Usa | Usa | 64401310001 | ||||||
| ELLIS, Martyn Anthony | Geschäftsführer | c/o Saga Healthcare Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire England | England | British | 95749550002 | |||||
| FINE, Robert | Geschäftsführer | 111 Ashley Avenue Brielle New Jersey 08730 Usa | American | 54235090001 | ||||||
| FISHER, Amanda Lucia | Geschäftsführer | The Rowans Merretts Orchard GL2 7DS Sumbridge Gloucestershire | England | British | 174485990001 | |||||
| GIBSON, Darryn Stanley | Geschäftsführer | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | 177930490001 | |||||
| GREEN, George Richard | Geschäftsführer | Selhurst Park House, Selhurst Park, Halnaker PO18 0LZ Chichester West Sussex | England | British | 4795650003 | |||||
| GREEN, George Richard | Geschäftsführer | Selhurst Park House, Selhurst Park, Halnaker PO18 0LZ Chichester West Sussex | England | British | 4795650003 | |||||
| HOWARD, Stuart Michael | Geschäftsführer | c/o Saga Healthcare Enbrook Park Sandgate CT20 3SE Folkestone 2 Kent England | United Kingdom | British | 160271430001 | |||||
| IVERS, John Joseph | Geschäftsführer | c/o Saga Healthcare Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire England | United Kingdom | British | 77692980002 | |||||
| JOHNSON, David Ian | Geschäftsführer | 6 Mill Farm Court Chebsey ST21 6HZ Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | 46008570001 | |||||
| KERNAHAN, Charles Lloyd | Geschäftsführer | The Old Barn Main Street Sutton On Trent NG23 6PF Newark Nottinghamshire | British | 50116330001 | ||||||
| LAVERY, Daniel Mark | Geschäftsführer | 23 Cornwall House Portland Crescent HG1 2TR Harrogate North Yorkshire | British | 111619010001 | ||||||
| MACHIN, Joanne | Geschäftsführer | Lakhpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House England | England | British | 236304960001 | |||||
| MASON, Catherine Lois | Geschäftsführer | Lakhpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House England | England | British | 224233880001 | |||||
| MOFFATT, David Stewart | Geschäftsführer | 2 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JT London | England | British | 88747420001 | |||||
| MOSELEY, Frederick | Geschäftsführer | 173 Larch Row Wenham Massachussetts Ma 01984 Usa | American | 67910480001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Geschäftsführer | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Geschäftsführer | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Healthcare Group Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Lakhpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ALLIED HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Floating security document | Erstellt am 19. Juli 2004 Geliefert am 28. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash collateral account | Erstellt am 22. Jan. 2003 Geliefert am 06. Feb. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to the cash collateral account and the charged balance where the account is the interest bearing sterling deposit account opened maintained and held by the chargee with account number 50451347 sort code 20-77-67 and designated barclays bank re staffing enterprise loan note account which includes any sub-account re-designation or substitution of said account. The charged balance means all monies standing to the credit of the cash collateral account with all interest accruing therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over collateral account | Erstellt am 15. Okt. 2002 Geliefert am 28. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right title and interest in the cash collateral account being the interest bearing sterling deposit account opened maintained and held by the chargee with account number 80358355 sort code 20-77-67 and designated barclays bank re j s bal loan note account and includes any sub-account any redesignation of that account and any account substituted as the cash collateral account by written agreement between the parties, and the charged balance being all monies from time to time standing to the credit of the cash collateral account together with the interest accruing thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash collateral account | Erstellt am 30. Juli 2002 Geliefert am 09. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The cash collateral account and the charged balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A charge over earn out account and acquisition expenditure account made by the company in favour of barclays bank PLC as security agent for and on behalf of the beneficiaries set out in the intercreditor deed (the "security agent") | Erstellt am 27. Sept. 2001 Geliefert am 05. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations owing to the beneficiaries or to the security agent (whether for its own account or on behalf of the beneficiaries) by the obligors under or pursuant to the finance documents (including the debenture) whether present or future, actual or contingent (and whether incurred solely or jointly and whether as principal or surety or in some other capacity) | |
Kurze Angaben Each credit balance from time to time on the earn out account number 20421677 sort code 20-77-67 and on the acquisition expenditure account number 30776576. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A charge over cash collateral account | Erstellt am 27. Sept. 2001 Geliefert am 05. Okt. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan note guarantee facility | |
Kurze Angaben All monies from time to time standing to the credit of the sterling deposit account number 20478776 sort code 20-77-67 with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash collateral account | Erstellt am 02. Aug. 2001 Geliefert am 09. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under the loan note guarantee facility of even date | |
Kurze Angaben All its right title and interest in the cash collateral account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash collateral account | Erstellt am 15. Juni 2001 Geliefert am 27. Juni 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee (the guarantee bank) under the loan note guarantee facility (as defined) | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all its right title and interest in all monies from time to time standing to the credit of the cash collateral account - account no.90076120. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Dez. 1999 Geliefert am 23. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations of transworld healthcare (UK) limited (the obligor) to the chargee as agent and security agent for and on behalf of the beneficiaries on the terms and conditions set out in the intercreditor deed under or pursuant to the finance documents (including the debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Dez. 1999 Geliefert am 23. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations of transworld healthcare (UK) limited (the obligor) to the chargee as agent and security agent for and on behalf of the beneficiaries on the terms and conditions set out in the intercreditor deed under or pursuant to the finance documents (including the debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0