MORRISON MERLIN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMORRISON MERLIN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03371720
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MORRISON MERLIN LIMITED?

    • Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen
    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich MORRISON MERLIN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    31 Bruton Place
    W1J 6NN London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MORRISON MERLIN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2015

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MORRISON MERLIN LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MORRISON MERLIN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2015

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 17. Juli 2015

    • Kapital: GBP 9,369,065
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2014

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 19. Juni 2014

    • Kapital: GBP 9,369,065
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2013

    15 SeitenAA

    Ernennung von Mrs Valérie Jeanine Ingelbrecht als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Severine Desnos als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Xavier Pullen als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2013 bis 31. Okt. 2013

    3 SeitenAA01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 52 Grosvenor Gardens London SW1W 0AU* am 12. Nov. 2013

    2 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Stuart Wetherly als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Kenneth Ford als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung 033717200019

    43 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 16 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von MORRISON MERLIN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    INGELBRECHT, Valérie Jeanine
    Bruton Place
    W1J 6NN London
    31
    Sekretär
    Bruton Place
    W1J 6NN London
    31
    184383560001
    DESNOS, Severine Geraldine Marie
    Bruton Place
    W1J 6NN London
    31
    Geschäftsführer
    Bruton Place
    W1J 6NN London
    31
    FranceFrench182808250001
    DESAI, Falguni Rameshchandra
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    Sekretär
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    British77755390004
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Sekretär
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Sekretär
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Sekretär
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    British1500260013
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Sekretär
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Sekretär
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    WETHERLY, Stuart Andrew
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    Sekretär
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0AU London
    52
    177523200001
    FETTER SECRETARIES LIMITED
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    Sekretär
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    71203580001
    DESAI, Falguni Rameshchandra
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    Geschäftsführer
    Apartment 108
    20 Palace Street
    SW1E 5BA London
    EnglandBritish77755390004
    DICK, Robert John Westwater
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    British246770002
    DONNELLY, Anthony
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    Geschäftsführer
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    United KingdomBritish109258700001
    FORD, Kenneth Charles
    Hans Place
    SW1X 0JZ London
    43
    Geschäftsführer
    Hans Place
    SW1X 0JZ London
    43
    EnglandBritish52710005
    FRITH, Roger Mark
    4 Avenue South
    KT5 8PJ Surbiton
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Avenue South
    KT5 8PJ Surbiton
    Surrey
    British79071980001
    JEFFERSON, Andrew Gordon
    17 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    17 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Midlothian
    British63406350001
    JEVANS, Peter Theodore
    White Cottage
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Geschäftsführer
    White Cottage
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritish35560390001
    JURY, Graham Richard
    6 Strachan Place
    SW19 4RH London
    Geschäftsführer
    6 Strachan Place
    SW19 4RH London
    British5973370001
    LAWSON, Andrew Gordon
    One The Paddock Seton Mains
    EH32 0PG Longniddry
    East Lothian
    Geschäftsführer
    One The Paddock Seton Mains
    EH32 0PG Longniddry
    East Lothian
    British45002240001
    MACCONNELL, Alasdair Murray
    3 Kettil'stoun Court
    EH49 6PS Linlithgow
    West Lothian
    Geschäftsführer
    3 Kettil'stoun Court
    EH49 6PS Linlithgow
    West Lothian
    ScotlandBritish54405740002
    MONK, Allan
    Lyncroft 2 Ryburn Avenue
    Beardwood
    BB2 7AU Blackburn
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Lyncroft 2 Ryburn Avenue
    Beardwood
    BB2 7AU Blackburn
    Lancashire
    British57852540001
    PULLEN, Xavier
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    Geschäftsführer
    65 Studdridge Street
    SW6 3SL London
    EnglandBritish78912170008
    RUSSELL, Peter
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    Geschäftsführer
    52 Moorfield
    Edgeworth
    BL7 0DH Bolton
    Manchester
    EnglandBritish10920180001
    SUNNUCKS, William D'Urban
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    Geschäftsführer
    East Gores Farm
    Salmons Lane
    CO6 1RZ Coggeshall
    Essex
    EnglandBritish32866350001
    WALLACE, Lesley Ann
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    British64383520003
    WINWARD, Martin Johnson
    Entwhistle House
    Entwhistle
    BL7 0LR Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Entwhistle House
    Entwhistle
    BL7 0LR Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish17166820001
    FETTER INCORPORATIONS LIMITED
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    Geschäftsführer
    C/O Kendall Freeman
    43 Fetter Lane
    EC4A 1JU London
    71203570001

    Hat MORRISON MERLIN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 31. Okt. 2013
    Geliefert am 08. Nov. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    F/H land k/a great northern centre watson street manchester t/no.GM829282. L/h k/a civic square peter street manchester t/no.GM796494. F/h land k/a land forming part of great bridgewater street manchester t/no.GM794105. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Deed of comfirmation
    Erstellt am 04. Okt. 2005
    Geliefert am 11. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 17. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the east side of deansgate manchester t/n GM829282, l/h civic square peter street manchester t/n GM796494, f/h great bridgewater street manchester t/n GM794105 the proceeds of sale and benefit of covenants.
    Berechtigte Personen
    • Capital & Regional PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 17. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Capital & Regional PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 06. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 06. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Its right title and interest in and the benefit of the agreements for lease, the developments documents, all amounts due under anu development documents and the benefit of any guarantee or security. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security over a deposit in a bank or building society
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 06. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the secured accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 06. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All the property k/a land and buildings on the east isde of deansgate manchester t/n GM829282 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 05. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Awg Group Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 05. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Awg Developments Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 05. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Morrison Merlin Great Northern Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 05. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Firstly all that f/h property known as land and buildings on the east side of deansgate, manchester t/n GM829282. Secondly all that l/h property known as the civic square, peter street, manchester t/n GM796494. Thirdly all that f/h property forming part of great bridgewater street, manchester t/n GM794105. Together with all buildings, fixtures and other structures. By way of fixed equitable charge, any beneficial interest the company may have in the property, in any compensation or insurance money and in any proceeds of sale, the benefit of the personal covenants.
    Berechtigte Personen
    • Awg Group Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 05. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Firstly all that f/h property known as land and buildings on the east side of deansgate, manchester t/n GM829282. Secondly all that l/h property known as the civic square, peter street, manchester t/n GM796494. Thirdly all that f/h property forming part of great bridgewater street, manchester t/n GM794105. Together with all buildings, fixtures and other structures. By way of fixed equitable charge, any beneficial interest the company may have in the property, in any compensation or insurance money and in any proceeds of sale, the benefit of the personal covenants.
    Berechtigte Personen
    • Awg Developments Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 05. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Firstly all that f/h property known as land and buildings on the east side of deansgate, manchester t/n GM829282. Secondly all that l/h property known as the civic square, peter street, manchester t/n GM796494. Thirdly all that f/h property forming part of great bridgewater street, manchester t/n GM794105. Together with all buildings, fixtures and other structures. By way of fixed equitable charge, any beneficial interest the company may have in the property, in any compensation or insurance money and in any proceeds of sale, the benefit of the personal covenants.
    Berechtigte Personen
    • Morrison Merlin Great Northern Limited
    Transaktionen
    • 05. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Nov. 1999
    Geliefert am 26. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the financing documents
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Westdeutsche Immobilienbank as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of benefits and certain contracts and rights
    Erstellt am 19. Nov. 1999
    Geliefert am 26. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the credit agreement and the hedging contract and any of the security documents as defined therein
    Kurze Angaben
    All right title and interest in each of the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Westdeutsche Immobilienbank as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 1998
    Geliefert am 31. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land shown edged in red on the plan attached to the debenture being part of the land under t/nos. GM711671 and GM713228 and fronting deansgate manchester city centre. L/h land shown edged green on the plan being land fronting peter street and watson street manchester city centre and l/h land shown edged purple on the plan being land situated between windmill street and watson street manchester city centre. Floating charge over all undertaking other property assets and rights including stock in trade and book debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Urban Regeneration Agency (Known as English Partnerships)
    Transaktionen
    • 31. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Juli 1998
    Geliefert am 24. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (including without limitation, all monies, obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred to the bank under or pursuant to the facility agreement (as defined) and/or the principal deed) and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a great northern warehouse manchester t/no: GM711671 and l/h land situated at watson street manchester t/no: GM342200 (part) all buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures) and fixed plant and machinery thereon floating charge over all its undertaking assets and rights .. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 24. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juli 1997
    Geliefert am 09. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (including without limitation all monies, obligations and liabilities hereafter due or owing or incurred to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined)) and/or this deed and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 09. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0