KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED

KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED
    UnternehmensstatusUmwandlung / Auflösung
    RechtsformUmwandlung / Auflösung
    Unternehmensnummer 03372093
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    • Einzelhandel in nicht spezialisierten Geschäften mit Nahrungsmitteln, Getränken oder Tabakwaren (47110) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PRICESTORE LIMITED16. Mai 199716. Mai 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis11. Jan. 2015

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verschiedenes

    Forms b & z convert to rs
    2 SeitenMISC

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Convert to rs 02/06/2016
    RES13

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 02. Juni 2016

    • Kapital: GBP 2,800,002
    3 SeitenSH01

    Ernennung von Mr David Roberts als Direktor am 01. Apr. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Steven Clive Bailey als Geschäftsführer am 01. Apr. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 28. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 2,800,000
    SH01

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2015

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 01. Mai 2015

    • Kapital: GBP 2,800,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Jan. 2014

    4 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 02. Jan. 2015 bis 11. Jan. 2015

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 29. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 2,800,000
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 06. Mai 2014

    • Kapital: GBP 2,800,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Jan. 2013

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * New Century House Corporation Street Manchester M60 4ES* am 03. Dez. 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Ernennung von Cws (No.1) Limited als Direktor

    2 SeitenAP02

    Ernennung von Mr Steven Clive Bailey als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Humes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Hurrell als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Jan. 2011

    4 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Hurrell am 01. Aug. 2010

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SELLERS, Caroline Jane
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    Sekretär
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    British45801060004
    ROBERTS, David Francis
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish200852560001
    CWS (NO.1) LIMITED
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer1925625
    130695310001
    COBURN, Ian David
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    Sekretär
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    British3000420001
    COUSINS, Alan Gordon Arthur
    94 Bridge Road
    SO31 7EP Sarisbury Green
    Hampshire
    Sekretär
    94 Bridge Road
    SO31 7EP Sarisbury Green
    Hampshire
    British57534360001
    WHITTAKER, Katherine Alison
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    22 Westfield Drive
    Woodley
    SK6 1LD Stockport
    Cheshire
    British29899300002
    EXCELLET INVESTMENTS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Sekretär
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    1872620003
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BAILEY, Steven Clive
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish95753690002
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Geschäftsführer
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritish87486660004
    CHEYNE, David George Thomson
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Covert 98 Woodlands Road
    Ashurst
    SO40 7AH Southampton
    Hampshire
    BritainBritish74956170001
    CLAPHAM, David John
    4 Heritage Hill
    BR2 6AU Keston
    Kent
    Geschäftsführer
    4 Heritage Hill
    BR2 6AU Keston
    Kent
    United KingdomBritish29705630001
    COBURN, Ian David
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    Geschäftsführer
    6 Sorrel Drive
    GU18 5PB Lightwater
    Surrey
    British3000420001
    HENSHAW, Stephen Anthony
    Aylesbury House
    Horsebridge Road Broughton
    SO20 8BD Stockbridge
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Aylesbury House
    Horsebridge Road Broughton
    SO20 8BD Stockbridge
    Hampshire
    British91828160001
    HOLLAND, Joseph
    87 Chapleton Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    87 Chapleton Road
    Bromley Cross
    BL7 9LZ Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish14141950001
    HOOKE, Anthony Arnold
    Cedars Wildwood Gardens
    Dingels Lane Cricket Hill
    GU46 6EB Yateley
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Cedars Wildwood Gardens
    Dingels Lane Cricket Hill
    GU46 6EB Yateley
    Hampshire
    British69353000002
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Geschäftsführer
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish84087790001
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish99724260001
    LAWSON, Stuart
    Treetops Smithwood Avenue
    GU6 8PS Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    Treetops Smithwood Avenue
    GU6 8PS Cranleigh
    Surrey
    British60361810001
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish106997230001
    ROBSON, William Henry Mark
    90 Springfield Road
    SL4 3PH Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    90 Springfield Road
    SL4 3PH Windsor
    Berkshire
    British57803420001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    QUICKNESS LIMITED
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    Geschäftsführer
    Senator House
    85 Queen Victoria Street
    EC4V 4JL London
    47109420002

    Hat KENNET & AVON CONVENIENCE STORES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Erstellt am 31. Mai 2001
    Geliefert am 06. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee and each of the secured parties
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Security Trustee for Itself and the Secured Parties (as Defined) (the "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 06. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Mai 1999
    Geliefert am 21. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a 105A junction road andover hampshire and the proceeds of sale all planat machinery fixtures and fittings goodwill and the benefit of the option dated 18/05/99.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Apr. 1999
    Geliefert am 12. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Premises known as the maisonette/shop at 2/3 atholl court,kingsway gardens andover; see form 395. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Feb. 1999
    Geliefert am 25. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 150A junction road andover hampshire the benefit of the option dated 23 february 1999 between the company and alldays stores limited. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 1999
    Geliefert am 28. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Ground floor shop and first floor office premises at 5 queens road farnborough hants. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Jan. 1999
    Geliefert am 07. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ground floor shop premises and first and second floor maisonettes at 1/5 elizabeth parade tudor drive yateley hants. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1998
    Geliefert am 24. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 570 wokingham road earley reading-BK84581 assigned the benefit of the option dated 10TH november 1998 between the company and alldays stores limited relating to the property (the option). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Nov. 1998
    Geliefert am 09. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at 8 alexandra road north camp farnborough hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of variation to a legal charge dated 21 august 1998
    Erstellt am 20. Okt. 1998
    Geliefert am 28. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property means the ground floor shop premises at 286 gosbrook road caversham reading berkshire.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 1998
    Geliefert am 30. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property k/a 109/113 queens road aldershot hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Sept. 1998
    Geliefert am 18. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at ash street ash surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Aug. 1998
    Geliefert am 09. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Piece or parcel of land at the ground floor shop premises at 286 gosbrook road caversham reading berkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juni 1998
    Geliefert am 15. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ground floor shop premises at 1 and 2 giles court brookside walk tadley hampshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. März 1998
    Geliefert am 18. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Kurze Angaben
    The company charges the property being land at ground floor shop premises at 53 high street aldershot hampshire GU11 1BH t/n-HP371495 (to the full extent of the company's interest in the property or its proceeds of sale) by way of legal mortagage of all legal interests and otherwise by way of specific equitable charge, assigned the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property subject to re-assignment on redemption, by way of fixed charge all the plant machinery and fixtures and fittings equipment and utensils, all the present or future goodwill of any business.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 1997
    Geliefert am 24. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a ground floor and basement 55/57 erleigh road reading berkshire the goodwill of the business and the benefit of the option dated 23 december 1997 between the company and alldays stores limited. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Nov. 1997
    Geliefert am 19. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Ground floor and basement at 133/135 oxford road reading berkshire RG1 7UU t/n BK285171 all legal ineterests and otherwise by specific equitable charge assinged the benefit of all covenants and rights fixed charge all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements utensils all present or future goodwill of any business assigns the benefit of the option of even date.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 21. Okt. 1997
    Geliefert am 24. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 5TH february 1990
    Kurze Angaben
    The rent deposit being an amount equal to 6 months rent from time to time firstly reserved by the lease being at the date of creation of the charge a deposit of £6,500.
    Berechtigte Personen
    • Double Reading Limited
    Transaktionen
    • 24. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Okt. 1997
    Geliefert am 24. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    That piece or parcel of land at 1 anstey close, basingstoke, hampshire and the goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Sept. 1997
    Geliefert am 12. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Piece or parcel of land at 27/31 high street chobham surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Sept. 1997
    Geliefert am 12. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Piece or parcel of land at 37 guildford road lightwater surrey. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Aug. 1997
    Geliefert am 27. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    That piece or parcel of land at 8 alexandra road north camp farnborough hants t/no.HP527455 and goodwill of any business.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Aug. 1997
    Geliefert am 22. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 132 cove road farnborough hants t/no HP504574 by way of fixed charge all the present or future goodwill of any business. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Aug. 1997
    Geliefert am 22. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Juli 1997
    Geliefert am 28. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alldays Stores Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Juli 1997
    Geliefert am 28. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alldays Franchising Limited
    Transaktionen
    • 28. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0