MINORPLANET SYSTEMS PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMINORPLANET SYSTEMS PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 03372097
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    • (7415) /

    Wo befindet sich MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    BDO LLP
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PIXIEDEAL PLC16. Mai 199716. Mai 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    17 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2017

    17 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Bdo Llp 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5RU zum Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 20. Apr. 2017

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2016

    11 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:Sec. Of State Cert of Release of Liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:co to remove/replace liquidator
    13 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2015

    23 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2014

    17 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Okt. 2013

    19 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 30. Okt. 2012

    10 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Mai 2012

    12 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    2 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    47 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    20 Seiten2.16B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Nov. 2011

    11 Seiten2.24B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Nov. 2011

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über das automatische Ende der Verwaltung

    9 Seiten2.30B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Nov. 2011

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Mai 2011

    17 Seiten2.24B

    Wer sind die Geschäftsführer von MINORPLANET SYSTEMS PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HOPKIN, Richard
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Sekretär
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    British12491060010
    DONOVAN, Terence John
    Glebe House
    The Terrace Boston Spa
    LS23 6AH Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Glebe House
    The Terrace Boston Spa
    LS23 6AH Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish101474510001
    HOPKIN, Richard
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    37 The Meadows
    HX6 2UN Sowerby Bridge
    West Yorkshire
    EnglandBritish12491060010
    HURLEY, Carolanne
    Flowery Fields Cottage
    Common Road
    ST8 7SR Biddulph Park
    Flowery Fields Cottage
    Staffs
    Geschäftsführer
    Flowery Fields Cottage
    Common Road
    ST8 7SR Biddulph Park
    Flowery Fields Cottage
    Staffs
    EnglandEnglish80127620002
    WALKER, Andrew William
    The Fields Linton Road
    Collingham
    LS22 5BS Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Fields Linton Road
    Collingham
    LS22 5BS Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish12066700001
    BYWELL, Robert Howard
    Moorlands
    Moorbottom Lane
    BD16 4HA Bingley
    West Yorkshire
    Sekretär
    Moorlands
    Moorbottom Lane
    BD16 4HA Bingley
    West Yorkshire
    British72284400001
    KELLY, Robert Daniel
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    Sekretär
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    British71715970001
    KING, Andrew Paul
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    Sekretär
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    British24333360002
    MELTHAM, John David
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    Sekretär
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    British74570910001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Sekretär
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Scottish146642810001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    WESTLEX REGISTRARS LIMITED
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    Sekretär
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    39191480001
    ABRAHAMS, Michael David
    Newfield
    Mickley
    HG4 3JH Ripon
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Newfield
    Mickley
    HG4 3JH Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritish5117870001
    ALEXANDER, Charles Edward
    1 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    Geschäftsführer
    1 Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    British32134300001
    BENNETT, Philip William
    Scalvert Parade
    Newport
    New South Wales 2106
    Geschäftsführer
    Scalvert Parade
    Newport
    New South Wales 2106
    Australian130990430001
    BEST, David Martin
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish47892490001
    FISH, Graham Stewart
    The Old School House
    Church Street
    LE17 6EZ North Kilworth
    Leicester
    Geschäftsführer
    The Old School House
    Church Street
    LE17 6EZ North Kilworth
    Leicester
    United KingdomBritish181919010001
    GAUNT, David Benjamin
    1a Saint Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    1a Saint Winifreds Road
    HG2 8LN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish91939970001
    HARRISON, Christopher Gerard, Professor
    11 Ringley Park
    Whitefield
    M45 7NT Manchester
    Geschäftsführer
    11 Ringley Park
    Whitefield
    M45 7NT Manchester
    EnglandBritish50288450002
    JACOMB, Martin Wakefield
    Manor Cottage
    Mill Lane, Adderbury
    OX17 3LW Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Manor Cottage
    Mill Lane, Adderbury
    OX17 3LW Banbury
    Oxfordshire
    British75361610004
    JARVIS, John Michael
    2 Greystone Park
    TN14 6EB Sundridge
    Kent
    Geschäftsführer
    2 Greystone Park
    TN14 6EB Sundridge
    Kent
    EnglandBritish80470600001
    KEATING, James
    Robinscourt
    Model Farm Road
    IRISH Cork
    County Cork
    Ireland
    Geschäftsführer
    Robinscourt
    Model Farm Road
    IRISH Cork
    County Cork
    Ireland
    IrelandIrish34330720001
    KELLY, Neil
    Beverley 22 Hill Top Road
    Stockton Heath
    WA4 2EF Warrington
    Geschäftsführer
    Beverley 22 Hill Top Road
    Stockton Heath
    WA4 2EF Warrington
    EnglandBritish11745350004
    KELLY, Robert Daniel
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Stafford House
    33 Stafford Hill Lane
    HD5 0EE Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish71715970001
    KING, Andrew Paul
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    Geschäftsführer
    12 Princess Mead
    Goldsborough
    HG5 8NP Knaresborough
    N Yorkshire
    British24333360002
    MACEY, John Dennis
    27 Whitegates Crescent
    Willaston
    L64 2UX South Wirral
    Geschäftsführer
    27 Whitegates Crescent
    Willaston
    L64 2UX South Wirral
    British51013920001
    MCBRIDE, John Kristian Lars
    61 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DN London
    Geschäftsführer
    61 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DN London
    EnglandBritish54651830001
    MELTHAM, John David
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    Geschäftsführer
    Willow Garth
    Howden Croft Hill, Ellerker
    HU15 2DE Brough
    North Humberside
    United KingdomBritish74570910001
    MORRIS, Jeffrey Clive
    Moor End Farm
    Harewood Avenue
    LS17 9HL East Keswick
    Leeds
    Geschäftsführer
    Moor End Farm
    Harewood Avenue
    LS17 9HL East Keswick
    Leeds
    United KingdomBritish10648420001
    PERRY, David Gordon
    Deighton House
    York Road
    YO19 6HQ Deighton
    York
    Geschäftsführer
    Deighton House
    York Road
    YO19 6HQ Deighton
    York
    British6323460001
    SPOONER, James Douglas, Sir
    Swire House
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Geschäftsführer
    Swire House
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    British35374990005
    TILLMAN, Andrew Daniel
    Hill Dean
    Barrowby Lane Kirby Overblow
    HG3 1HQ Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Hill Dean
    Barrowby Lane Kirby Overblow
    HG3 1HQ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish36748120001
    WOODS, Lucy Ann
    Ballencrief Road
    RG27 8JY Sunningdale
    Windlestream Cottage
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ballencrief Road
    RG27 8JY Sunningdale
    Windlestream Cottage
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish89944470003
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001

    Hat MINORPLANET SYSTEMS PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over shares
    Erstellt am 13. Mai 2010
    Geliefert am 01. Juni 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in and to the securities all dividends all stocks shares and the securities system rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Digicore International Holdings Bv
    Transaktionen
    • 01. Juni 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 09. Feb. 2010
    Geliefert am 19. Feb. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Tcjm Limited
    Transaktionen
    • 19. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 03. Sept. 2009
    Geliefert am 12. Sept. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Asbury Park S.A.R.L
    Transaktionen
    • 12. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 04. Sept. 2008
    Geliefert am 09. Sept. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 26. Sept. 2006
    Geliefert am 29. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of a deposit account pursuant to the terms of the rent deposit deed.
    Berechtigte Personen
    • Sanderson Logistics Limited
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Mai 2006
    Geliefert am 20. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 28. Juni 2005
    Geliefert am 18. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Equity Holdings Inc & Terence Donovan
    Transaktionen
    • 18. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 15. Nov. 2004
    Geliefert am 27. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ge Capital Equity Holdings, Inc (As Security Trustee for the Secured Creditors)
    Transaktionen
    • 27. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge/security over shares
    Erstellt am 13. Jan. 2004
    Geliefert am 22. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All securities and their proceeds of sale, all dividends, interest and other distributions paid in respect of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 2002
    Geliefert am 18. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 2 and 4 meanwood road leeds t/no WYK532960. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Escrow account charge
    Erstellt am 11. Juni 2002
    Geliefert am 11. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee charges by way of first fixed charge to hfgl all of its right title and interest in and to the account of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hfgl Limited
    Transaktionen
    • 11. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Feb. 2002
    Geliefert am 15. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a city garage manor street sheepscar leeds t/no WYK456290. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Nov. 2001
    Geliefert am 23. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a peregrine house gelderd close gelderd road leeds t/n WYK301906. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Okt. 1997
    Geliefert am 31. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 31. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MINORPLANET SYSTEMS PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Nov. 2010Beginn der Verwaltung
    08. Nov. 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Dermot Justin Power
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    2
    DatumTyp
    09. Nov. 2011Beginn der Verwaltung
    30. Okt. 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Dermot Justin Power
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    Praktiker
    Bdo Llp
    1 Bridgewater Place
    LS11 5RU Water Lane
    Leeds
    3
    DatumTyp
    30. Okt. 2012Beginn der Liquidation
    08. Sept. 2018Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Dermot Justin Power
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0