ARKLE SECURITIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameARKLE SECURITIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03372506
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ARKLE SECURITIES LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich ARKLE SECURITIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ARKLE SECURITIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GORT SECURITIES LIMITED19. Mai 199719. Mai 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ARKLE SECURITIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ARKLE SECURITIES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ARKLE SECURITIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    13 Seiten4.72

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    5 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    9 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Nov. 2013

    22 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Mai 2013

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    7 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    25 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O King Loose St John's Parade 5 South Parade Summertown Oxford OX2 7JL am 30. Nov. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    6 SeitenLQ01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Apr. 2012

    Kapitalaufstellung am 26. Apr. 2012

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    accounts-with-accounts-type-

    9 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Noel Martin Smyth am 04. Nov. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    accounts-with-accounts-type-

    8 SeitenAA

    Ernennung von Allannah Smyth als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Bryan Lawlor als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von John Mckenna als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Bryan Lawlor als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von ARKLE SECURITIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SMYTH, Allannah
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    Sekretär
    Portobello Road
    Dublin 8
    29
    Ireland
    154679050001
    KINNAIRD, Nigel John
    14 Magheraconluce Lane
    BT26 6PT Hillsborough
    County Down
    Geschäftsführer
    14 Magheraconluce Lane
    BT26 6PT Hillsborough
    County Down
    Northern IrelandBritish83042830001
    LAWLOR, Bryan
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    Dublin 16
    17
    Ireland
    Geschäftsführer
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    Dublin 16
    17
    Ireland
    IrelandIrish154652750001
    SMYTH, Noel Martin
    25 Tooting Bec Road
    SW17 8BY London
    Flat 7
    England
    Geschäftsführer
    25 Tooting Bec Road
    SW17 8BY London
    Flat 7
    England
    IrelandIrish91238420002
    CHALK, Peter Henry
    6 Brechin Place
    SW7 4QA London
    Sekretär
    6 Brechin Place
    SW7 4QA London
    British1483500001
    DUDLEY, Martin Paul
    Horsebrook House
    51 Old Farm Drive
    WV8 1GF Codsall
    Wolverhampton
    Sekretär
    Horsebrook House
    51 Old Farm Drive
    WV8 1GF Codsall
    Wolverhampton
    British93516350001
    GIBSON, Jacqueline
    7 Manor Court
    Beech Road Headington
    OX3 7SD Oxford
    Oxfordshire
    Sekretär
    7 Manor Court
    Beech Road Headington
    OX3 7SD Oxford
    Oxfordshire
    British84250850001
    KINDER, Emily Jane Mcrae
    46 Scholars Road
    Balham
    SW12 0PG London
    London
    Sekretär
    46 Scholars Road
    Balham
    SW12 0PG London
    London
    British82805500001
    LAWLOR, Bryan William
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    21
    Dublin 16
    Republic Of Ireland
    Sekretär
    Coolamber Court
    Knocklyon Road
    21
    Dublin 16
    Republic Of Ireland
    Irish154652750014
    LONG, Phillipa Katie Victoria
    26 Halford Road
    SW6 1JT Fulham
    London
    Sekretär
    26 Halford Road
    SW6 1JT Fulham
    London
    British75810820001
    LUMSDEN, Thomas Anthony
    7 Drew Place
    CR3 5FE Caterham
    Surrey
    Sekretär
    7 Drew Place
    CR3 5FE Caterham
    Surrey
    British54391990003
    NOEL, Sarah Kate
    16 Stratford Road
    W8 6QD London
    Sekretär
    16 Stratford Road
    W8 6QD London
    British61371370001
    SELAK, Amela
    1st Floor Flat
    37 Croxley Road
    W9 3HH London
    Sekretär
    1st Floor Flat
    37 Croxley Road
    W9 3HH London
    Bosnian66491330001
    TEDESCO, Lori Ellen
    10 Lennox Garden Mews
    SW1 London
    Sekretär
    10 Lennox Garden Mews
    SW1 London
    American52766470001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    DUDLEY, Martin Paul
    Horsebrook House
    51 Old Farm Drive
    WV8 1GF Codsall
    Wolverhampton
    Geschäftsführer
    Horsebrook House
    51 Old Farm Drive
    WV8 1GF Codsall
    Wolverhampton
    United KingdomBritish93516350001
    GWYN JONES, Henry Alexander
    4 Rue Desaix
    Paris
    75008
    France
    Geschäftsführer
    4 Rue Desaix
    Paris
    75008
    France
    British69720680007
    MCKENNA, John
    34 Brighton Square Rathgar
    IRISH Dublin 6
    Republic Of Ireland
    Geschäftsführer
    34 Brighton Square Rathgar
    IRISH Dublin 6
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish116525480001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Hat ARKLE SECURITIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 06. Feb. 2008
    Geliefert am 12. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/Hold land and buildings known as hopetown office park,brinkburn road,darlington; du 70317. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Trustees Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 06. Feb. 2008
    Geliefert am 12. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest into any agreements,contracts,deeds,licences,undertakings,guarantees and any rental income and disposal proceeds thereon; any insurance policies and all proceeds payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Trustees Limited
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 06. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each borrower to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to form 395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled share capital buildings and fixtures,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Subordination agreement
    Erstellt am 22. Feb. 2007
    Geliefert am 08. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Under the subordination agreement, if: any obligor makes any payment in cash or in kind on account of, or for the purchase or other acquisition of, all or any part of the junior liabilities; or the company receives all or any amount in cash or in kind of the junior liabilities:. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited as Agent for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 08. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 2007
    Geliefert am 08. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The mortgaged property being 2 admiral way, the post office building, doxford international business pk, sunderland t/no TY406866; the regus building, 4 admiral way, doxford, sunderland t/no TY406864; 37A waterloo st and bennetts hill, birmingham t/no WM422047, for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Trustees Limited, as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 08. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture with floating charge
    Erstellt am 22. Feb. 2007
    Geliefert am 08. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage the mortgaged property, assignment any rental income, insurance policies, the hedge documents, fixed charges the real property, the property account, the gic account, book and other debts, goodwill and uncalled share capital, scottish property, scottish shares, jersey shares, floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Trustees Limited as Security Trustee for Each of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 08. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 117. Mai 2012Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 1
    Junior supplemental debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2005
    Geliefert am 10. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The shares and all its present and future investments rental income insurace policies goodwill by way of floating charge all present and future assets and undertaking
    Kurze Angaben
    L/H property k/a the property k/a th epost office building doxford international business park sunderland t/n TY406866 l/h property k/a the regus building doxford international business park sunderland t/n TY406866 right title and interest to, in and under all agreements contracts deeds licences undertakings guarantees covenants warranties rental income insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Trust Company (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture with floating charge
    Erstellt am 29. Sept. 2005
    Geliefert am 10. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as gort securities limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a kiln house pottergate norwich t/n NK73767 f/h property k/a stephenson house northumbrian way killingworth tyne and wear l/h property k/a cater house 49/50 high street chelmsford essex and parking spaces t/n EX372858 EX446160 and EX359767 the shares and all its present and future investments rental income insurace policies goodwill by way of floating charge all present and future assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nm Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture with floating charge
    Erstellt am 29. Sept. 2005
    Geliefert am 10. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as gort securities limited to the lender and/or the security trustee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a kiln house pottergate norwich t/n NK73767 f/h property k/a stephenson house northumbruan way killingworth tyne and wear t/n TY88302 l/h property k/a cater house 49/50 high street chelmsford essex and parking spaces t/n EX372858 EX446160 and EX359767RIGHT title and interest to, in and under all agreements contracts deeds licences undertakings guarantees covenants warranties rental income insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Trust Company Limited (The Security)
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Senior supplemental debenture
    Erstellt am 29. Sept. 2005
    Geliefert am 10. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as gort securities limited to the lender and/or the security trustee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All l/h property k/a the post office building doxford international business park sunderland t/n TY406866 l/h property k/a the regus building doxford international business park sunderland t/n TY406864 right title and interest to,in and under all agreements contracts deeds licences undertakings guarantees covenants warranties rental income insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capita Trust Company Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A mortgage of shares
    Erstellt am 01. Feb. 2005
    Geliefert am 04. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the shares owned and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juni 2004
    Geliefert am 08. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Stephenson house northumbrian way killingworth tyne and wear t/n TY88302 by way of fixed charge its interest in all fittings plant equipment machinery tools vehicles furniture and other tangible movable property, any investment, all receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 25. Sept. 2003
    Geliefert am 27. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge its interest in the account and all money now or at any time after the date of the charge agreement credited to or standing to the credit of the account together with accrued interest. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 29. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the interest in the account being account number 333-269115-01 and all money now or at any time credited to or standing to the credit of the account, together with accrued interest.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over securities
    Erstellt am 13. Mai 2003
    Geliefert am 16. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Any and all sums due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the issued share capital of gort property investments limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over securities
    Erstellt am 13. Mai 2003
    Geliefert am 16. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Any and all sums due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the issued share capital of august investments limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge pursuant to a mortgage debenture dated 2 december 1997
    Erstellt am 29. Nov. 2002
    Geliefert am 03. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that freehold land known as 37A waterloo street and 7 bennetts hill birmingham west midlands t/n WM422047 and all buildings and fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2002
    Geliefert am 05. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a 21/22 grosvenor street and 21/22 brook mews london comprised in an underlease of even date (as defined therein) and all buildings fixtures and fittings, all plant and machinery, vehicles, computers, office and other equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge pursuant to a mortgage debenture dated 2 december 1997
    Erstellt am 30. Aug. 2001
    Geliefert am 04. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land/buildings on the north side of brinkburn rd,darlington; t/no du 70317; all buildings fixtures fittings plant machinery vehicles thereon.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 04. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party deed of charge over securities
    Erstellt am 19. Feb. 2001
    Geliefert am 21. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from st.giles investments limited the co mpany or any person who is a party to any document (a related security document) to the chargee under or pursuant to the terms of the facility agreement the deed or any related security document or on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All of the company's present and future rights title and interest in and to (1) all of the issued share capital of st.giles investments limited which may from time to time be legally and or beneficially owned by the company being at the date hereof one ordinary share of £1 pound each (2) any other shares stocks and securities issued to the company to be substituted from time to time for those shares stocks and securities listed above (3) all interest dividends cash or otherwise the bonus issues distributions allotments offers by way of rights benefits proceeds and entitlements.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 04. Apr. 2000
    Geliefert am 06. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a kiln house pottergate norwich - EX359767 together with all buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 21. Okt. 1999
    Geliefert am 22. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1). l/h land being 49 and 50 high street chelmsford EX372858, 2). l/h at rear of 49/50 chelmsford high street EX359767 3). l/h land being land on east side of high street chelmsford t/no;-EX446160 and all buildings fixtures (inc. Trade fixtures and fittins ) fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 28. Mai 1998
    Geliefert am 02. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 35, 39, 41 and 53 harwood road t/no.NGL625114 and 17 harwood road t/no.NGL607571 and all buildings fixtures fittings (including trade fixtures and fittings fixed plant and machinery).
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge taken pursuant to a mortgage debenture dated 2ND december 1997 and
    Erstellt am 14. Mai 1998
    Geliefert am 16. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 38/40 rye lane t/no SGL175433 and all buildings fixtures and fittings (including trade fixtures) & fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal charge (pursuant to a mortgage debenture dated 2ND december 1997)
    Erstellt am 21. Apr. 1998
    Geliefert am 06. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 22,24,26,28 turnham green terrace t/n AGL46034 and f/h land k/a 18 and 20 turnham green terrace t/n AGL46033 and all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ARKLE SECURITIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kevin Peter Mersh
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    United Kingdom
    Receiver Manager
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    United Kingdom
    Julian Marshal Clarke
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    Receiver Manager
    20 Grosvenor Hill
    Berkeley Square
    W1K 3HQ London
    2
    DatumTyp
    20. Nov. 2012Beginn der Verwaltung
    15. Nov. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praktiker
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praktiker
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    3
    DatumTyp
    15. Nov. 2013Beginn der Liquidation
    27. Apr. 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas H O'Reilly
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praktiker
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praktiker
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praktiker
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0