SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03372510 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?
- (8531) /
Wo befindet sich SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bridge House, Outwood Lane Horsforth LS18 4UP Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicholas Tetley Beazley am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon Philip Reiter am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mahboob Ali Merchant am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Ellerby am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bupa House 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London | 107319700001 | |||||||
| BEAZLEY, Nicholas Tetley | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 105797560001 | |||||
| ELLERBY, Mark | Geschäftsführer | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | 40582650004 | |||||
| GREGORY, Fraser David | Geschäftsführer | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | 107664270001 | |||||
| MERCHANT, Mahboob Ali | Geschäftsführer | 28 Denham Road KT17 3AA Epsom Surrey | United Kingdom | British | 56732410001 | |||||
| REITER, Simon Philip | Geschäftsführer | Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House 15-19 England | United Kingdom | British | 135845570001 | |||||
| BHAYANI, Hitesh Prahbudas | Sekretär | 24 Mountington Park Close HA3 0NW Harrow Middlesex | British | 69162500001 | ||||||
| DALY, Geoffrey William Stuart | Sekretär | 97 Valiant House Vicarage Crescent SW11 3LX London | British | 19464860001 | ||||||
| KING, Robert Frederick | Sekretär | 8 Prior Bolton Street Canonbury N1 2NX London | British | 10012650001 | ||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Sekretär | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 34893920001 | |||||||
| BHAYANI, Hitesh Prahbudas | Geschäftsführer | 24 Mountington Park Close HA3 0NW Harrow Middlesex | British | 69162500001 | ||||||
| BHAYANI, Sudhen Prabhudas | Geschäftsführer | 80 Barn Hill HA9 9LQ Wembley Middlesex | England | British | 43452460001 | |||||
| DALY, Geoffrey William Stuart | Geschäftsführer | Sixpenny Buckle Coldhouse Hill GU22 0QS Woking Surrey | United Kingdom | British | 19464860003 | |||||
| DAVIES, Julian Peter | Geschäftsführer | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 29367700001 | |||||
| DHANDSA, Narinder, Dr | Geschäftsführer | D102 Montevetro 100 Battersea Church Road Battersea SW11 3YL London | England | British | 115844000001 | |||||
| KENT, Benjamin David Jemphrey | Geschäftsführer | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 93897360003 | |||||
| RAINER, Christopher Nihal | Geschäftsführer | 20 West Hill Sanderstead CR2 0SA South Croydon Surrey | United Kingdom | British | 55660630001 | |||||
| SINCLAIR BROWN, Frederick John | Geschäftsführer | Rudge House Itchel Lane Crondall GU10 5PR Farnham Surrey | United Kingdom | British | 8070730003 | |||||
| SINCLAIR BROWN, Frederick John | Geschäftsführer | 13 Sudbrooke Road SW12 8TG London | British | 8070730001 | ||||||
| TAYLOR, Neil Robert | Geschäftsführer | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | 62846800003 | |||||
| WACKETT, Leonard Walter | Geschäftsführer | 46 Bramber Way RH15 8JX Burgess Hill West Sussex | British | 48549700001 | ||||||
| WALFORD, Arthur David | Geschäftsführer | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 6658190001 | |||||
| WICKER, Frederick Alan | Geschäftsführer | 39 Lloyd Road KT4 8SA Worcester Park Surrey | United Kingdom | English | 1969460001 | |||||
| ANS NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 1 Battersea Square SW11 3PZ London | 68699250001 | |||||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Hat SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 09. Jan. 2004 Geliefert am 14. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 30. Juni 2003 Geliefert am 08. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fieldway nursing home, mitcham, surrey t/n TGL103067 and any buildings fixtures fittings fixed plant or machinery and all related rights. All the company's right title and interest to in and under all proceeds of any insurance policy and all related rights and all agreements contracts deeds licences undertakings guarantees covenants warranties representations and other documents. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Juni 2003 Geliefert am 17. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest from time to time in and to each of the following assets the real property, the tangible moveable property, the account, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares all monetary claims. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Juli 2002 Geliefert am 05. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Juli 2002 Geliefert am 05. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a filedway nursery and residential care home south of tramway park mitcham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Juli 1999 Geliefert am 16. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land k/a the fieldway nursing centre mitcham l/b of merton greater london t/no: TGL103067. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Juli 1999 Geliefert am 16. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Aug. 1997 Geliefert am 19. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £200,000 due from the company to the chargee in accordance with the provisions of clause 6.8 of a deed dated 19TH june 1997 | |
Kurze Angaben Land and buildings at tramway path mitcham t/n-TGL103067. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of a building contract relating to a development of a freehold nursing home at tramway path,mitcham,title no.tgl 103067 | Erstellt am 19. Juni 1997 Geliefert am 09. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben All rights under the building contract. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Juni 1997 Geliefert am 09. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over bank accounts | Erstellt am 19. Juni 1997 Geliefert am 09. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement of even date | |
Kurze Angaben All rights,title and interest in the account monies on acct/no 60518077. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Juni 1997 Geliefert am 09. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property - tramway path,mitcham; t/no tgl 103067 with the goodwill of business and all licences,guarantees and covenants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0