SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED

SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03372510
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?

    • (8531) /

    Wo befindet sich SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Bridge House, Outwood Lane
    Horsforth
    LS18 4UP Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Nicholas Tetley Beazley am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Änderung der Details des Direktors für Simon Philip Reiter am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mahboob Ali Merchant am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mark Ellerby am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    legacy

    5 Seiten363a

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 07/01/2009
    RES13

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    5 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    11 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    16 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Sekretär
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Geschäftsführer
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270001
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Geschäftsführer
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish56732410001
    REITER, Simon Philip
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    Geschäftsführer
    Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House 15-19
    England
    United KingdomBritish135845570001
    BHAYANI, Hitesh Prahbudas
    24 Mountington Park Close
    HA3 0NW Harrow
    Middlesex
    Sekretär
    24 Mountington Park Close
    HA3 0NW Harrow
    Middlesex
    British69162500001
    DALY, Geoffrey William Stuart
    97 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LX London
    Sekretär
    97 Valiant House
    Vicarage Crescent
    SW11 3LX London
    British19464860001
    KING, Robert Frederick
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    Sekretär
    8 Prior Bolton Street
    Canonbury
    N1 2NX London
    British10012650001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    Sekretär
    42-46 High Street
    KT10 9QY Esher
    Surrey
    34893920001
    BHAYANI, Hitesh Prahbudas
    24 Mountington Park Close
    HA3 0NW Harrow
    Middlesex
    Geschäftsführer
    24 Mountington Park Close
    HA3 0NW Harrow
    Middlesex
    British69162500001
    BHAYANI, Sudhen Prabhudas
    80 Barn Hill
    HA9 9LQ Wembley
    Middlesex
    Geschäftsführer
    80 Barn Hill
    HA9 9LQ Wembley
    Middlesex
    EnglandBritish43452460001
    DALY, Geoffrey William Stuart
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Sixpenny Buckle
    Coldhouse Hill
    GU22 0QS Woking
    Surrey
    United KingdomBritish19464860003
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    DHANDSA, Narinder, Dr
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    Geschäftsführer
    D102 Montevetro
    100 Battersea Church Road Battersea
    SW11 3YL London
    EnglandBritish115844000001
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    RAINER, Christopher Nihal
    20 West Hill
    Sanderstead
    CR2 0SA South Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    20 West Hill
    Sanderstead
    CR2 0SA South Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish55660630001
    SINCLAIR BROWN, Frederick John
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Rudge House
    Itchel Lane Crondall
    GU10 5PR Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish8070730003
    SINCLAIR BROWN, Frederick John
    13 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    Geschäftsführer
    13 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    British8070730001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Geschäftsführer
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritish62846800003
    WACKETT, Leonard Walter
    46 Bramber Way
    RH15 8JX Burgess Hill
    West Sussex
    Geschäftsführer
    46 Bramber Way
    RH15 8JX Burgess Hill
    West Sussex
    British48549700001
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001
    WICKER, Frederick Alan
    39 Lloyd Road
    KT4 8SA Worcester Park
    Surrey
    Geschäftsführer
    39 Lloyd Road
    KT4 8SA Worcester Park
    Surrey
    United KingdomEnglish1969460001
    ANS NOMINEES LIMITED
    1 Battersea Square
    SW11 3PZ London
    Geschäftsführer
    1 Battersea Square
    SW11 3PZ London
    68699250001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Hat SUTTON COURT HOMES (NO.2) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 09. Jan. 2004
    Geliefert am 14. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 14. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 08. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fieldway nursing home, mitcham, surrey t/n TGL103067 and any buildings fixtures fittings fixed plant or machinery and all related rights. All the company's right title and interest to in and under all proceeds of any insurance policy and all related rights and all agreements contracts deeds licences undertakings guarantees covenants warranties representations and other documents. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 08. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Juni 2003
    Geliefert am 17. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest from time to time in and to each of the following assets the real property, the tangible moveable property, the account, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares all monetary claims. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 17. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 05. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juli 2002
    Geliefert am 05. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a filedway nursery and residential care home south of tramway park mitcham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 05. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a the fieldway nursing centre mitcham l/b of merton greater london t/no: TGL103067. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Juli 1999
    Geliefert am 16. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Aug. 1997
    Geliefert am 19. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £200,000 due from the company to the chargee in accordance with the provisions of clause 6.8 of a deed dated 19TH june 1997
    Kurze Angaben
    Land and buildings at tramway path mitcham t/n-TGL103067.
    Berechtigte Personen
    • Ans Staff Services (Sutton Court) Limited
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of a building contract relating to a development of a freehold nursing home at tramway path,mitcham,title no.tgl 103067
    Erstellt am 19. Juni 1997
    Geliefert am 09. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    All rights under the building contract. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Juni 1997
    Geliefert am 09. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over bank accounts
    Erstellt am 19. Juni 1997
    Geliefert am 09. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement of even date
    Kurze Angaben
    All rights,title and interest in the account monies on acct/no 60518077. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Juni 1997
    Geliefert am 09. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property - tramway path,mitcham; t/no tgl 103067 with the goodwill of business and all licences,guarantees and covenants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Ucb Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0