GARETH JAMES PHARMACY LIMITED

GARETH JAMES PHARMACY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGARETH JAMES PHARMACY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03375701
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GARETH JAMES PHARMACY LIMITED?

    • (5231) /

    Wo befindet sich GARETH JAMES PHARMACY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Sandbrook Park, Sandbrook Way
    Rochdale
    OL11 1RY Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GARETH JAMES PHARMACY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis10. Jan. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für GARETH JAMES PHARMACY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony John Smith am 31. Juli 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Branson Nuttall am 31. Juli 2010

    2 SeitenCH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Mai 2010

    Kapitalaufstellung am 20. Mai 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Peter Batty als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mrs Caroline Jane Sellers als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Katherine Eldridge als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 10. Jan. 2009

    20 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 12. Jan. 2008

    20 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2007

    23 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten225

    Wer sind die Geschäftsführer von GARETH JAMES PHARMACY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SELLERS, Caroline Jane
    Sandbrook Park, Sandbrook Way
    Rochdale
    OL11 1RY Lancashire
    Sekretär
    Sandbrook Park, Sandbrook Way
    Rochdale
    OL11 1RY Lancashire
    150066860001
    NUTTALL, John Branson
    13 Green Villa Park
    SK9 6EJ Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    13 Green Villa Park
    SK9 6EJ Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritish44967060002
    SMITH, Anthony John
    Three Mile Lane
    ST5 5HW Whitmore
    Hillside Lodge
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Three Mile Lane
    ST5 5HW Whitmore
    Hillside Lodge
    Staffordshire
    EnglandBritish137558680001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Sekretär
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    JAMES, Susan Laura
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    Sekretär
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    British53038800002
    MATHIAS, Clive Stanley
    1 The Mews
    St Nicholas Road
    CF62 6QX Barry
    Vale Of Glamorgan
    Sekretär
    1 The Mews
    St Nicholas Road
    CF62 6QX Barry
    Vale Of Glamorgan
    British90539780002
    SELLERS, Caroline Jane
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    Sekretär
    1 Gale Close
    Littleborough
    OL15 9EJ Rochdale
    Lancashire
    British45801060004
    BATTY, Peter David
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Church Hill
    Ingham
    LN1 2YE Lincoln
    2
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140380300001
    BRAITHWAITE, Neil
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    Geschäftsführer
    74 Stockton Lane
    YO31 1BN York
    EnglandBritish87486660004
    BROCKLEHURST, Jonathan David
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Larch House
    29 Keele Road
    ST5 2JT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British49108820004
    DUGGAN, Rachel
    18 Mentone Road
    Heaton Moor
    SK4 4HF Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    18 Mentone Road
    Heaton Moor
    SK4 4HF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish122443900001
    FARQUHAR, Gordon Hillocks
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    Geschäftsführer
    3 Apsley Grove
    Dorridge
    B93 8QP Solihull
    United KingdomBritish125645380001
    JAMES, Gareth Lloyd
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    WalesBritish58499330001
    JAMES, Susan Laura
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage Vicarage Drive
    Pontardawe
    SA8 4PB Swansea
    WalesBritish53038800002
    JONES, Ailsa Michelle
    16 Northways
    CF36 5LB Porthcawl
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    16 Northways
    CF36 5LB Porthcawl
    Mid Glamorgan
    British116649550001
    WANLISS, Mike
    2 Ridgeview
    Off Scott Close
    LE16 7GJ Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    2 Ridgeview
    Off Scott Close
    LE16 7GJ Market Harborough
    Leicestershire
    British120288660001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001
    FARMERS FABRICATIONS LIMITED
    Eos House
    Weston Square
    CF63 2YF Barry
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    Eos House
    Weston Square
    CF63 2YF Barry
    South Glamorgan
    44551190001

    Hat GARETH JAMES PHARMACY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 30. Juni 2006
    Geliefert am 01. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Aug. 2005
    Geliefert am 30. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a the pharmacy llanybydder dyfed. Fixed and floating charge over undertaking property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy intination dated 17/03/04 and
    Erstellt am 11. März 2004
    Geliefert am 18. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Company: scottish provident, policy number: 12184958, date: 16/04/2003, sum: £1,300,000, life assured: gareth lloyd james/susan laura james together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy intimation dated 17/03/04 and
    Erstellt am 11. März 2004
    Geliefert am 18. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Company: scottish provident, policy number: 12182633, sum: £2800000, life assured: gareth lloyd james/susan laura james together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Juni 2003
    Geliefert am 13. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juni 2003
    Geliefert am 13. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Peglers building, 1-5 pontardulais road, gorseinon, swansea t/n CYM39275. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juni 2003
    Geliefert am 13. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 alexandra road, gorseinon t/n WA930290. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juni 2003
    Geliefert am 13. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    47/49 charles street, milford haven t/n CYM15196. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Mai 2002
    Geliefert am 11. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H property the new pharmacy gowerton surgery mill street gowerton swansea.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transaktionen
    • 11. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juni 2001
    Geliefert am 09. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H peglers building 1-5 pontardulais road gorseinon swansea and all rights attached or appurtenant to it and all buildings fixtures fititngs plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Bristol) Limited
    Transaktionen
    • 09. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Nov. 2000
    Geliefert am 25. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property 2 alexandra road gorseinon swansea 150-152 station road llanelli 33 terrace road aberystwyth fixed and floating charges over the undertaking and all property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Okt. 2000
    Geliefert am 14. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 47/49 charles street milford haven pembrokshire fixed charge all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Nov. 1999
    Geliefert am 18. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 33 terrace road aberystwyth any goodwill of any business. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Nov. 1999
    Geliefert am 18. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 2 alexandra road gorseinon swansea any goodwill of any business. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Nov. 1999
    Geliefert am 18. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 150/152 station road llanelli any goodwill of any business. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 18. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Okt. 1999
    Geliefert am 26. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Medical Finance (Retail) Limited
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Nov. 1998
    Geliefert am 04. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aah Pharmaceuticals Limited
    Transaktionen
    • 04. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 01. Juni 1998
    Geliefert am 04. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property being 33 terrace rd,aberystwyth. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 1998
    Geliefert am 18. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 1997
    Geliefert am 18. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge all its undertaking and property both present and future including its uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0