BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED

BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBORDER RADIO HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03376590
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Anthony Keenan am 25. Sept. 2018

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    4 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Deidre Ann Ford am 30. Sept. 2016

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Sarah Jane Vickery am 30. Sept. 2016

    2 SeitenCH01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2016 bis 31. Dez. 2016

    1 SeitenAA01

    Ernennung von Bauer Group Secretariat Limited als Sekretär am 05. Mai 2016

    2 SeitenAP04

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    15 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Juli 2016

    Kapitalaufstellung am 28. Juli 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mrs Sarah Jane Vickery am 14. Juli 2016

    3 SeitenCH01

    Ernennung von Mrs Sarah Jane Vickery als Direktor am 05. Mai 2016

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Deidre Ann Ford als Direktor am 05. Mai 2016

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Paul Anthony Keenan als Direktor am 05. Mai 2016

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Philip Stephen Riley als Geschäftsführer am 05. Mai 2016

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Roy Evans als Sekretär am 05. Mai 2016

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Mark Roy Evans als Geschäftsführer am 05. Mai 2016

    2 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 172 10/06/2016
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    13 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Sekretär
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United KingdomBritishManaging Director109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritishPublisher243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritishFinance Director119137220004
    CUSICK, Nicholas Jonathan Paul
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    Sekretär
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    British50942120001
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector54693600002
    FITZJOHN, Julie
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    Sekretär
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    BritishAccountant92875290001
    FLUET, Cliff
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    Sekretär
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    British97684290001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Sekretär
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director116537370001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Sekretär
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Sekretär
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    SCHWARZ, Nathalie Esther
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    Sekretär
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    BritishCompany Secretary59245010001
    BROWNLOW, Peter
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    BritishManaging Director4459070001
    BURGESS, Robert Lawie Frederick
    Hall Flatt
    Scaleby
    CA6 4LE Carlisle
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Hall Flatt
    Scaleby
    CA6 4LE Carlisle
    Cumbria
    United KingdomBritishChief Executive Officer61711750001
    CORLEY, Paul
    3 Willoughby Street
    WC1A 1JD London
    Geschäftsführer
    3 Willoughby Street
    WC1A 1JD London
    BritishChief Executive60591660003
    EVANS, Mark Roy
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritishDirector54693600002
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director54693600002
    FAIRBURN, Paul Martin
    9 Tansley Gardens
    Dorridge
    B93 8UB Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    9 Tansley Gardens
    Dorridge
    B93 8UB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishBroadcasting Manager43039880003
    FITZJOHN, Julie
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    Geschäftsführer
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    United KingdomBritishAccountant92875290001
    GRAHAM, James Lowery
    Oak House
    Great Corby
    CA4 8NE Carlisle
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Oak House
    Great Corby
    CA4 8NE Carlisle
    Cumbria
    BritishChief Executive Officer2014530001
    HARRIS, Peter Jonathan
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    Geschäftsführer
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    EnglandBritishFinance Director40917640001
    MANSFIELD, David James
    16 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    Geschäftsführer
    16 Sudbrooke Road
    SW12 8TG London
    United KingdomBritishChief Executive32585450001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Geschäftsführer
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director116537370001
    MYERS, John Frederick
    21 Middle Drive
    Darras Hal
    NE20 9DH Ponteland
    Northumberland
    Geschäftsführer
    21 Middle Drive
    Darras Hal
    NE20 9DH Ponteland
    Northumberland
    BritishManaging Director70386430001
    PARK, Richard Francis Jackson
    55 Gloucester Crescent
    NW1 7EG London
    Geschäftsführer
    55 Gloucester Crescent
    NW1 7EG London
    EnglandBritishDirector75081070002
    QUINN, Andrew
    Kilnholme
    Penton
    CA6 5QZ Carlisle
    Geschäftsführer
    Kilnholme
    Penton
    CA6 5QZ Carlisle
    BritishCompany Director42394270002
    RILEY, Philip Stephen
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Geschäftsführer
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritishDirector140085310001
    TABOR, Ashley Daniel
    Apartment 11-02
    The Knightsbridge Apartments, 199 Knightsbridge
    SW17 1RH London
    Geschäftsführer
    Apartment 11-02
    The Knightsbridge Apartments, 199 Knightsbridge
    SW17 1RH London
    United KingdomBritishManaging Director56313240002
    THOMSON, Donald Alexander
    Shelley Lodge
    104 West Street
    SL7 2BP Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Shelley Lodge
    104 West Street
    SL7 2BP Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCommercial Director37668550003
    TRIMBLE, David William
    Deepdale
    Dalston
    CA5 7BH Carlisle
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Deepdale
    Dalston
    CA5 7BH Carlisle
    Cumbria
    BritishDirector11476910001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06. Apr. 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer3050677
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 20. Mai 2011
    Geliefert am 27. Mai 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the note issuer and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Andrew Price
    Transaktionen
    • 27. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 20. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Matthew Paul Ramsbottom
    Transaktionen
    • 20. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 29. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 20. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robert John Norman
    Transaktionen
    • 20. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 18. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Geoffrey Percy
    Transaktionen
    • 18. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 05. Mai 2010
    Geliefert am 13. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from orion media holdings limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Global Radio Group Limited
    Transaktionen
    • 13. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Philip Riley
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery a specific equitable charge over all freehold & leasehold properties &/or the proceeds of sale thereof, fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present & future including goodwill, book debts & the benefit of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Antony Thomas Lloyd
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 05. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All land vested in or charged to the chargor, all fixtures and fittings attached to the land and all rents, all plant & machinery, contacts goodwill uncalled capital stocks shares patents copyrights and all other intellectual property rights. A floating charge over all the other property assets and rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Apr. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 31. März 1999
    Geliefert am 09. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0