BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03376590 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Anthony Keenan am 25. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Deidre Ann Ford am 30. Sept. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Sarah Jane Vickery am 30. Sept. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2016 bis 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Bauer Group Secretariat Limited als Sekretär am 05. Mai 2016 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Sarah Jane Vickery am 14. Juli 2016 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Sarah Jane Vickery als Direktor am 05. Mai 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Deidre Ann Ford als Direktor am 05. Mai 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Anthony Keenan als Direktor am 05. Mai 2016 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Stephen Riley als Geschäftsführer am 05. Mai 2016 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Roy Evans als Sekretär am 05. Mai 2016 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Roy Evans als Geschäftsführer am 05. Mai 2016 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 13 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED | Sekretär | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom |
| 159023720001 | ||||||||||
FORD, Deidre Ann | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House | United Kingdom | British | Managing Director | 109666380002 | ||||||||
KEENAN, Paul Anthony | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House | England | British | Publisher | 243390510001 | ||||||||
VICKERY, Sarah Jane | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House | England | British | Finance Director | 119137220004 | ||||||||
CUSICK, Nicholas Jonathan Paul | Sekretär | 30 Longlands Road CA3 9AD Carlisle | British | 50942120001 | ||||||||||
EVANS, Mark Roy | Sekretär | 17 Carless Avenue B17 9BN Birmingham West Midlands | British | Director | 54693600002 | |||||||||
FITZJOHN, Julie | Sekretär | Basement Flat 78 Elgin Avenue W9 2HB London | British | Accountant | 92875290001 | |||||||||
FLUET, Cliff | Sekretär | 11 Rokesly Avenue N8 8NS London | British | 97684290001 | ||||||||||
HARRISON, Irene Lesley | Bevollmächtigter Sekretär | Fy Mwthin 22 Merthyr Road Tongwynlais CF15 7LH Cardiff South Glamorgan | British | 900003790001 | ||||||||||
MCGARTOLL, Owen Raphael | Sekretär | 58 The Anchorage, Clarence Street IRISH Dun Laoghaire County Dublin Ireland | Irish | Company Director | 116537370001 | |||||||||
POTTERELL, Clive Ronald | Sekretär | Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue KT7 0HF Thames Ditton Surrey | British | 3182530002 | ||||||||||
POTTERELL, Clive Ronald | Sekretär | Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue KT7 0HF Thames Ditton Surrey | British | 3182530002 | ||||||||||
SCHWARZ, Nathalie Esther | Sekretär | Flat 10 28 Belsize Avenue NW3 4AU London | British | Company Secretary | 59245010001 | |||||||||
BROWNLOW, Peter | Geschäftsführer | Quarry Bank Capon Hill CA8 1QN Brampton Cumbria | British | Managing Director | 4459070001 | |||||||||
BURGESS, Robert Lawie Frederick | Geschäftsführer | Hall Flatt Scaleby CA6 4LE Carlisle Cumbria | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 61711750001 | ||||||||
CORLEY, Paul | Geschäftsführer | 3 Willoughby Street WC1A 1JD London | British | Chief Executive | 60591660003 | |||||||||
EVANS, Mark Roy | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House | England | British | Director | 54693600002 | ||||||||
EVANS, Mark Roy | Geschäftsführer | 17 Carless Avenue B17 9BN Birmingham West Midlands | England | British | Finance Director | 54693600002 | ||||||||
FAIRBURN, Paul Martin | Geschäftsführer | 9 Tansley Gardens Dorridge B93 8UB Solihull West Midlands | England | British | Broadcasting Manager | 43039880003 | ||||||||
FITZJOHN, Julie | Geschäftsführer | Basement Flat 78 Elgin Avenue W9 2HB London | United Kingdom | British | Accountant | 92875290001 | ||||||||
GRAHAM, James Lowery | Geschäftsführer | Oak House Great Corby CA4 8NE Carlisle Cumbria | British | Chief Executive Officer | 2014530001 | |||||||||
HARRIS, Peter Jonathan | Geschäftsführer | 381 Wimbledon Park Road SW19 6PE London | England | British | Finance Director | 40917640001 | ||||||||
MANSFIELD, David James | Geschäftsführer | 16 Sudbrooke Road SW12 8TG London | United Kingdom | British | Chief Executive | 32585450001 | ||||||||
MCGARTOLL, Owen Raphael | Geschäftsführer | 58 The Anchorage, Clarence Street IRISH Dun Laoghaire County Dublin Ireland | Irish | Company Director | 116537370001 | |||||||||
MYERS, John Frederick | Geschäftsführer | 21 Middle Drive Darras Hal NE20 9DH Ponteland Northumberland | British | Managing Director | 70386430001 | |||||||||
PARK, Richard Francis Jackson | Geschäftsführer | 55 Gloucester Crescent NW1 7EG London | England | British | Director | 75081070002 | ||||||||
QUINN, Andrew | Geschäftsführer | Kilnholme Penton CA6 5QZ Carlisle | British | Company Director | 42394270002 | |||||||||
RILEY, Philip Stephen | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House | England | British | Director | 140085310001 | ||||||||
TABOR, Ashley Daniel | Geschäftsführer | Apartment 11-02 The Knightsbridge Apartments, 199 Knightsbridge SW17 1RH London | United Kingdom | British | Managing Director | 56313240002 | ||||||||
THOMSON, Donald Alexander | Geschäftsführer | Shelley Lodge 104 West Street SL7 2BP Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Commercial Director | 37668550003 | ||||||||
TRIMBLE, David William | Geschäftsführer | Deepdale Dalston CA5 7BH Carlisle Cumbria | British | Director | 11476910001 | |||||||||
BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Crown House 64 Whitchurch Road CF14 3LX Cardiff | 900005500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion Media (East Midlands) Limited | 06. Apr. 2016 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat BORDER RADIO HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 20. Mai 2011 Geliefert am 27. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the note issuer and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 05. Mai 2010 Geliefert am 20. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 05. Mai 2010 Geliefert am 20. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 05. Mai 2010 Geliefert am 18. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the note issuer to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 05. Mai 2010 Geliefert am 13. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from orion media holdings limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Juli 2009 Geliefert am 06. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Juli 2009 Geliefert am 06. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Juli 2009 Geliefert am 06. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery a specific equitable charge over all freehold & leasehold properties &/or the proceeds of sale thereof, fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present & future including goodwill, book debts & the benefit of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Juli 2009 Geliefert am 05. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All land vested in or charged to the chargor, all fixtures and fittings attached to the land and all rents, all plant & machinery, contacts goodwill uncalled capital stocks shares patents copyrights and all other intellectual property rights. A floating charge over all the other property assets and rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 31. März 1999 Geliefert am 09. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0