MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03379662 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Kingdom Street Paddington W2 6BL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BROKERCARE LIMITED | 20. Aug. 1997 | 20. Aug. 1997 |
| CHANCEFLAME LIMITED | 02. Juni 1997 | 02. Juni 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Nov. 2016 | 14 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 60 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 7 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. Aug. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Johannes Jacobus Olivier als Direktor am 20. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Paul Woodward als Geschäftsführer am 20. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Paul Woodward als Direktor am 05. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sanjay Patel als Geschäftsführer am 28. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Van Harken als Direktor am 31. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Mary Collins als Geschäftsführer am 31. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Misys Corporate Director Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARKEN, John Van | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | American | 183654340001 | |||||||||
| HOMER, Thomas Edward Timothy | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 146605570001 | |||||||||
| OLIVIER, Johannes Jacobus | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | South African | 199516920001 | |||||||||
| BRAIN, Sarah Elizabeth Highton | Sekretär | The Street Warninglid Haywards Heath RH17 5SZ West Sussex No 1 Portwood Cottage England England | 146627810001 | |||||||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Sekretär | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||||||
| GRAY, Elizabeth Andrea | Sekretär | 16 Broad Street CV34 4LT Warwick Warwickshire | British | 98035800001 | ||||||||||
| HAM, Richard Laurence | Sekretär | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | British | 136433670001 | ||||||||||
| WATERS, Paul Christopher | Sekretär | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||||||
| WILSON, Kevin Michael | Sekretär | Strauss Road Chiswick W4 1DL London 10 | Other | 138835080001 | ||||||||||
| MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom |
| 170448630001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BROOK, Anthony Richard | Geschäftsführer | Crofftau Cantref LD3 8LL Brecon Powys | British | 44545910001 | ||||||||||
| COLLINS, Elizabeth Mary | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 180406780001 | |||||||||
| COOK, John | Geschäftsführer | Barnside GL20 7BP Tredington Gloucestershire | England | British | 86208160001 | |||||||||
| COPELAND, Philip Robert | Geschäftsführer | Crofton Sheldon Road Ickford HP18 9HY Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 44954570001 | |||||||||
| DUDLEY, John Mark | Geschäftsführer | Eagle Way Hampton Vale PE7 8EA Peterborough 124 England England | Uk | British | 101918420001 | |||||||||
| EVANS, Howard | Geschäftsführer | Charlton Park House Charlton Park Gate GL53 7DJ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 56986700002 | |||||||||
| EVANS, Robert Owen | Gesch äftsführer | Field House Ashow CV8 2LE Kenilworth Warwickshire | British | 57011000002 | ||||||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Geschäftsführer | The Avenue Watford WD17 4NU Hertfordshire 51 England England | England | British | 75357260001 | |||||||||
| FLETCHER, Leonard James | Geschäftsführer | Long Cottage Compton Road RG20 7LH East Ilsley Berkshire | England | British | 74416740002 | |||||||||
| FULLELOVE, Glyn William | Geschäftsführer | Brook House Spout Lane Tansley DE4 5FH Matlock Derbyshire | United Kingdom | British | 73026210001 | |||||||||
| GRAHAM, Ross King | Geschäftsführer | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||||||
| HAM, Richard Laurence | Geschäftsführer | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | United Kingdom | British | 136433670001 | |||||||||
| HAWKES, Joanna Marageret | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 136214800001 | |||||||||
| JOHNSON, Russell Alan | Geschäftsführer | Worcester Avenue Kings Hill West Malling ME19 4FL Kent 14 England United Kingdom | British | 130788060001 | ||||||||||
| LEWIS, Richard | Geschäftsführer | Karisaro 50 Slade Avenue Lyppard Hanford WR4 0HB Worcester | British | 71966870001 | ||||||||||
| MARSH, Howard Alexander David | Geschäftsführer | 33 Rogers Way CV34 6PY Warwick | United Kingdom | British | 111938620001 | |||||||||
| MARTIN, Ivan | Geschäftsführer | 90 Ranelagh Road Ealing W5 5RP London | England | British | 123233030001 | |||||||||
| MCMAHON, Jasper Philip | Geschäftsführer | Ground Floor Flat 33 Warrington Crescent W9 1EJ London | England | British | 45080250003 | |||||||||
| O'LEARY, Michael Kevin | Geschäftsführer | Greenwood Wichenford WR6 6YB Worcester Worcestershire | England | British | 129193560001 | |||||||||
| PATEL, Bijal Mahendra | Geschäftsführer | Kingdom Street Paddington W2 6BL London One | United Kingdom | British | 161424380001 | |||||||||
| PATEL, Sanjay Surendra | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 147221810001 | |||||||||
| SIMPSON, David Alan | Geschäftsführer | Draycott Cottage Draycott Lane WR5 3NY Kempsey Worcestershire | England | British | 80817560001 | |||||||||
| SUSSENS, John Gilbert | Geschäftsführer | Blythe House 10 Grange Road Bidford On Avon B50 4BY Alcester Warwickshire | England | British | 1442450002 | |||||||||
| TAYLOR, David | Geschäftsführer | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 |
Hat MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 27. Juli 2012 Geliefert am 06. Aug. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All property,all the shares and investments and all corresponding related rights first fixed charge all other interests in any property and the benefit of all other agreements relating to land,all of its right title and interest in the charged intellectual property see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995 | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 29. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 01. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995 | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 24. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Erstellt am 29. Juli 2003 Geliefert am 12. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter) | Erstellt am 23. Okt. 2002 Geliefert am 13. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Erstellt am 09. Mai 2002 Geliefert am 25. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MISYS GROUP HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0