SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03379663 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
- Sonstige Software-Veröffentlichungen (58290) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Kingdom Street Paddington W2 6BL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DEMOABLE LIMITED | 02. Juni 1997 | 02. Juni 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Mai 2016 | 28 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 7 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Paul Woodward als Direktor am 05. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sanjay Patel als Geschäftsführer am 28. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Van Harken als Direktor am 31. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Mary Collins als Geschäftsführer am 31. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Misys Corporate Director Limited als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanna Hawkes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Misys Corporate Secretary Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Sanjay Patel als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Elizabeth Mary Collins als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bijal Patel als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Joanna Marageret Hawkes als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Bijal Mahendra Patel am 20. Mai 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Bijal Mahendra Patel als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARKEN, John Van | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | American | 183654340001 | |||||||||
| HOMER, Thomas Edward Timothy | Geschäftsführer | Maidenhead Road Cookham SL6 9DF Berkshire Rosedale United Kingdom | England | British | 146605570001 | |||||||||
| WOODWARD, Andrew Paul | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 100885620001 | |||||||||
| BRAIN, Sarah Elizabeth Highton | Sekretär | Portwood Cottage The Street Warninglid, Haywards Heath RH17 5SZ West Sussex No 1 England | British | 147213550001 | ||||||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Sekretär | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||||||
| GRAY, Elizabeth Andrea | Sekretär | 16 Broad Street CV34 4LT Warwick Warwickshire | British | 98035800001 | ||||||||||
| HAM, Richard Laurence | Sekretär | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | British | 136433670001 | ||||||||||
| WATERS, Paul Christopher | Sekretär | The Old Vicarage High Street B50 4BQ Bidford On Avon Warwickshire | British | 67435560001 | ||||||||||
| WILSON, Kevin Michael | Sekretär | Strauss Road Chiswick W4 1DL London 10 | Other | 138835080001 | ||||||||||
| MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom |
| 170449400001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BAULME, Herve | Geschäftsführer | 23 Avenue De L'Obersavtoire 75006 Paris France | French | 98573020001 | ||||||||||
| BELLOUARD, Xavier Henry Marie | Geschäftsführer | 14 Abinger Road W4 1EL London | London | French | 53755850003 | |||||||||
| BRIODY, Dermot | Geschäftsführer | Palm Drive The Redhill Peninsula Tai Tam House 34 Hong Kong Hong Kong | Irish | 128090250001 | ||||||||||
| CAPPELL, Mark Stanley | Geschäftsführer | Woodruff South Munstead Lane GU8 4AG Godalming Surrey | United Kingdom | American | 103054980001 | |||||||||
| COLLINS, Elizabeth Mary | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 180406780001 | |||||||||
| DE FONTENAY, Jean | Geschäftsführer | 440 East 62nd Street NY 10021 New York Usa | French | 53755800002 | ||||||||||
| EVANS, Robert Owen | Geschäftsführer | Field House Ashow CV8 2LE Kenilworth Warwickshire | British | 57011000002 | ||||||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Geschäftsführer | The Avenue WD17 4NU Watford 51 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 75357260001 | |||||||||
| GRAHAM, Ross King | Geschäftsführer | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||||||
| HAM, Richard Laurence | Geschäftsführer | High Street Welford-On-Avon CV37 8EA Stratford-Upon-Avon Avon House Warwickshire England | United Kingdom | British | 136433670001 | |||||||||
| HAWKES, Joanna Marageret | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | England | British | 136214800001 | |||||||||
| HELSBY, Frank Peter | Geschäftsführer | 27 Park Green Great Bookham KT23 3NL Leatherhead Surrey | England | British | 34237710003 | |||||||||
| HUGHES, Kevin Gerard | Geschäftsführer | 31 Cromwell Avenue Billericay CM12 OAG Essex | United Kingdom | British | 173214140001 | |||||||||
| HUGHES, Kevin Gerard | Geschäftsführer | 12 Linkdale CM12 9QW Billericay Essex | British | 2659400001 | ||||||||||
| MARTIN, Ivan | Geschäftsführer | 90 Ranelagh Road Ealing W5 5RP London | England | British | 123233030001 | |||||||||
| MOLONEY, Barry William | Geschäftsführer | Little Chantry Bull Lane SL9 8RH Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 48187880001 | |||||||||
| PATEL, Bijal Mahendra | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 161424380001 | |||||||||
| PATEL, Sanjay Surendra | Geschäftsführer | Paddington W2 6BL London One Kingdom Street United Kingdom | United Kingdom | British | 147221810001 | |||||||||
| SARGANT, Murray | Geschäftsführer | 10d, Block D, Grenville House No1 Magazine Gap Road Hong Kong Hong Kong | Australian | 113006830001 | ||||||||||
| SOAMES, Rupert Christopher | Geschäftsführer | Ridge Barn Farm House Ridgebarn Lane, Cuddington HP18 0AE Aylesbury Buckinghamshire | Scotland | British | 86671010001 | |||||||||
| STONELL, Keith Robert | Geschäftsführer | Tars Platt Cookham Dean Common SL6 9PY Cookham Dean Berkshire | England | British | 151579610001 | |||||||||
| SUSSENS, John Gilbert | Geschäftsführer | Blythe House 10 Grange Road Bidford On Avon B50 4BY Alcester Warwickshire | England | British | 1442450002 | |||||||||
| TAYLOR, David | Geschäftsführer | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 27. Juli 2012 Geliefert am 06. Aug. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All property,all the shares and investments and all corresponding related rights first fixed charge all other interests in any property and the benefit of all other agreements relating to land,all of its right title and interest in the charged intellectual property see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995 | Erstellt am 19. Dez. 2006 Geliefert am 29. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 17. Sept. 2003 Geliefert am 01. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995 | Erstellt am 11. Sept. 2003 Geliefert am 24. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and | Erstellt am 29. Juli 2003 Geliefert am 12. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter) | Erstellt am 23. Okt. 2002 Geliefert am 13. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 | Erstellt am 09. Mai 2002 Geliefert am 25. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SUMMIT SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0