FORMPRO MAIL MARKETING LIMITED

FORMPRO MAIL MARKETING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFORMPRO MAIL MARKETING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03380170
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FORMPRO MAIL MARKETING LIMITED?

    • (2222) /

    Wo befindet sich FORMPRO MAIL MARKETING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    100 Temple Street
    BS1 6AG Bristol
    Avon
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FORMPRO MAIL MARKETING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FORMPRO LIMITED22. Aug. 199722. Aug. 1997
    HYBIR LIMITED03. Juni 199703. Juni 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FORMPRO MAIL MARKETING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für FORMPRO MAIL MARKETING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 14. Dez. 2010

    18 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Juni 2010

    15 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Western Drive Hengrove Bristol BS14 0AZ am 19. Feb. 2010

    2 SeitenAD01

    Vorschlag des Verwalters

    38 Seiten2.17B

    Vorschlag des Verwalters

    1 Seiten2.17B

    Vorschlag des Verwalters

    1 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    14 Seiten2.16B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    Seiten395

    legacy

    10 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten88(2)

    legacy

    1 Seiten123

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12
    capital

    Beschluss zur Erhöhung des genehmigten Stammkapitals

    RES04

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    21 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    16 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von FORMPRO MAIL MARKETING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WRIGHT, Peter Malcolm Vanner
    Ley Farm
    Bere Ferrers
    PL20 7JF Yelverton
    Devon
    Sekretär
    Ley Farm
    Bere Ferrers
    PL20 7JF Yelverton
    Devon
    British40063630003
    ANDERSON, Paul
    Sundown 22 Over Lane
    Almondsbury
    BS32 4BP Bristol
    South Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Sundown 22 Over Lane
    Almondsbury
    BS32 4BP Bristol
    South Gloucestershire
    EnglandBritish58837060002
    HUGHES, Michael John
    Latcham Farm
    Latcham
    BS28 4SB Wedmore
    Somerset
    Geschäftsführer
    Latcham Farm
    Latcham
    BS28 4SB Wedmore
    Somerset
    EnglandBritish44908170005
    KING, Brent Alexander
    St Georges Hill
    Bathampton
    BA2 6RN Bath
    8
    Avon
    Geschäftsführer
    St Georges Hill
    Bathampton
    BA2 6RN Bath
    8
    Avon
    British135775310001
    MATTINSON, Colin Robert
    Meadowview
    Sisters Farm South Cerney
    GL7 5QE Cirencester
    Geschäftsführer
    Meadowview
    Sisters Farm South Cerney
    GL7 5QE Cirencester
    EnglandBritish109390030001
    WRIGHT, Peter Malcolm Vanner
    Ley Farm
    Bere Ferrers
    PL20 7JF Yelverton
    Devon
    Geschäftsführer
    Ley Farm
    Bere Ferrers
    PL20 7JF Yelverton
    Devon
    EnglandBritish40063630003
    HORLER, Mandy
    Chestnut House The Uplands
    Blackford Road
    TA9 4NP Mark
    Somerset
    Sekretär
    Chestnut House The Uplands
    Blackford Road
    TA9 4NP Mark
    Somerset
    British101007070001
    PETERS, Roger May
    80 Brook Street
    W1K 5DD London
    Sekretär
    80 Brook Street
    W1K 5DD London
    British6672810001
    WAKEFIELD, Joely Margaret
    18 Fallowfield Close
    Cepen Park North
    SN14 6YA Chippenham
    Wiltshire
    Sekretär
    18 Fallowfield Close
    Cepen Park North
    SN14 6YA Chippenham
    Wiltshire
    British111424970001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ANDREW, Peter
    Glanville Lodge
    Glanville Road
    BS28 4AD Wedmore
    Somerset
    Geschäftsführer
    Glanville Lodge
    Glanville Road
    BS28 4AD Wedmore
    Somerset
    British122230980001
    BRUCE COPP, Neil Dennis
    Hollybush House Church Road
    Ham
    TW10 5HG Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hollybush House Church Road
    Ham
    TW10 5HG Richmond
    Surrey
    British54307800003
    COOK, Tim
    The Croft Cottage Farm
    Winters Lane
    BS40 5SN Redhill
    North Somerset
    Geschäftsführer
    The Croft Cottage Farm
    Winters Lane
    BS40 5SN Redhill
    North Somerset
    British66655710002
    FAGNANI, Roberto
    Parklands
    Chelwood
    BS39 4NH Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    Parklands
    Chelwood
    BS39 4NH Bristol
    Avon
    United KingdomUnited Kingdom29577440001
    FRY, Mark
    Camden Terrace
    Clifton Vale
    BS8 4PU Bristol
    9
    Geschäftsführer
    Camden Terrace
    Clifton Vale
    BS8 4PU Bristol
    9
    British128863020001
    HOPKINSON, Neil Antony
    19a Station Road
    Backwell
    BS48 3NW Bristol
    Geschäftsführer
    19a Station Road
    Backwell
    BS48 3NW Bristol
    United KingdomBritish66465730003
    HORLER, Jonathan Howard
    Haygrove Road
    Durleigh
    TA6 7HZ Bridgwater
    Haygrove Manor
    Somerset
    Geschäftsführer
    Haygrove Road
    Durleigh
    TA6 7HZ Bridgwater
    Haygrove Manor
    Somerset
    EnglandBritish67840440006
    PERKINS, Raymond Adam
    Oaklands
    Cadbury Camp Lane
    BS20 7SB Clapton In Gordano
    North Somerset
    Geschäftsführer
    Oaklands
    Cadbury Camp Lane
    BS20 7SB Clapton In Gordano
    North Somerset
    United KingdomBritish39850980002
    SOPHER, Jon Andrew Victor
    Smerrill Barn
    Kemble
    GL7 6BW Cirencester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Smerrill Barn
    Kemble
    GL7 6BW Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish58720360003
    WAKEFIELD, Joely Margaret
    18 Fallowfield Close
    Cepen Park North
    SN14 6YA Chippenham
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    18 Fallowfield Close
    Cepen Park North
    SN14 6YA Chippenham
    Wiltshire
    British111424970001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Hat FORMPRO MAIL MARKETING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 28. Mai 2009
    Geliefert am 10. Juni 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juni 2009
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 27. Nov. 2007
    Geliefert am 08. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juli 2007
    Geliefert am 24. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • John Roderick Thomas Hubert Hughes and Michael John Hughes
    Transaktionen
    • 24. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2006
    Geliefert am 19. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Neil Bruce Copp and Michael John Hughes (The Debenture Holders)
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 20. Sept. 2005
    Geliefert am 22. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £687,000.00 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    The goods being the oschner reel to folded sheet line comprising single position shafted unwind stand tensioning rollers fife web guide for further details of the goods charged please refer to form 395 together with al accessories and component parts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. März 2005
    Geliefert am 30. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 29. Aug. 2003
    Geliefert am 09. Sept. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or horcopp group limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Jan. 2002
    Geliefert am 10. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. März 2001
    Geliefert am 03. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat FORMPRO MAIL MARKETING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Dez. 2010Ende der Verwaltung
    21. Dez. 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard John Hill
    Kpmg Llp
    100 Temple Street
    BS1 6AG Bristol
    Praktiker
    Kpmg Llp
    100 Temple Street
    BS1 6AG Bristol
    Jonathan Scott Pope
    Kpmg
    Marlborough House
    Fitzalan Court
    Fitzalan Road Cardiff Cf24 Ote
    Praktiker
    Kpmg
    Marlborough House
    Fitzalan Court
    Fitzalan Road Cardiff Cf24 Ote

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0