HALLMARK INDUSTRIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHALLMARK INDUSTRIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03385127
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BROOMCO (1300) LIMITED11. Juni 199711. Juni 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    20 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Nov. 2021

    20 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Nov. 2020

    19 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Nov. 2019

    15 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Orion House 5 Upper St. Martin's Lane London WC2H 9EA England zum Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road Whitefield M45 7TA am 06. Dez. 2018

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 08. Nov. 2018

    LRESSP

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2018

    17 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Parag Himatlal Gandesha als Geschäftsführer am 06. Apr. 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017

    18 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 02. Juni 2016

    • Kapital: GBP 26,819,730.66
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Mml Capital Partners Llp Grand Buildings 1-3 Strand London WC2N 5HR zum Orion House 5 Upper St. Martin's Lane London WC2H 9EA am 12. Jan. 2016

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2015

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 19. Juni 2015

    • Kapital: GBP 26,819,730.66
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2014

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 27. Mai 2014

    • Kapital: GBP 26,819,730.66
    SH01

    Ernennung von Mr Parag Himatlal Gandesha als Direktor

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Highland House 165 the Broadway Wimbledon London SW19 1NE England* am 04. Feb. 2014

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROOKS, Roderick Hilary
    c/o Mml Capital Partners Llp
    1-3 Strand
    WC2N 5HR London
    Grand Buildings
    England
    Geschäftsführer
    c/o Mml Capital Partners Llp
    1-3 Strand
    WC2N 5HR London
    Grand Buildings
    England
    United KingdomBritish64784320003
    JOHAL, Balbinder Singh
    c/o Mml Capital Partners Llp
    1-3 Strand
    WC2N 5HR London
    Grand Buildings
    England
    Geschäftsführer
    c/o Mml Capital Partners Llp
    1-3 Strand
    WC2N 5HR London
    Grand Buildings
    England
    United KingdomBritish124684440001
    WALLIS, Ian Scott
    Grand Buildings
    Strand
    WC2N 5HR London
    1-3
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Grand Buildings
    Strand
    WC2N 5HR London
    1-3
    United Kingdom
    EnglandBritish129726790001
    FOX, Andrew Joseph
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    Sekretär
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    British73079390002
    GIBSON, John
    Shaws Farm
    NE48 2JU Bellingham
    Northumberland
    Sekretär
    Shaws Farm
    NE48 2JU Bellingham
    Northumberland
    British19815410001
    PENMAN, Angus Warwick
    7 Red Anchor Close
    Old Church Street Chelsea
    SW3 5DW London
    Sekretär
    7 Red Anchor Close
    Old Church Street Chelsea
    SW3 5DW London
    British44192700001
    SCOTT, Christopher George
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    British94183390001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    BOLAND, Robert Jerome
    15 Manchester Road
    SK10 2EH Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    15 Manchester Road
    SK10 2EH Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish70534810001
    DAVIDSON, George Alexander
    The Waterfront
    300 Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Waterfront
    300 Thames Valley Park Drive
    RG6 1PT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish60518410002
    DAVIES, Colin Ernest
    The Granary
    Escrick Road
    YO19 6BQ York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Granary
    Escrick Road
    YO19 6BQ York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish78759470002
    FOX, Andrew Joseph
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    Geschäftsführer
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    EnglandBritish73079390002
    GANDESHA, Parag Himatlal
    5 Upper St. Martin's Lane
    WC2H 9EA London
    Orion House
    England
    Geschäftsführer
    5 Upper St. Martin's Lane
    WC2H 9EA London
    Orion House
    England
    United KingdomBritish142573260001
    GIBSON, John
    Shaws Farm
    NE48 2JU Bellingham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Shaws Farm
    NE48 2JU Bellingham
    Northumberland
    British19815410001
    GORDON CLARK, Matthew John
    104 Cloudesley Road
    N1 0EB London
    Geschäftsführer
    104 Cloudesley Road
    N1 0EB London
    United KingdomBritish101313810001
    KENT, Brian Hamilton
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    Geschäftsführer
    165 The Broadway
    Wimbledon
    SW19 1NE London
    Highland House
    England
    United KingdomBritish15133080001
    PENMAN, Angus Warwick
    7 Red Anchor Close
    Old Church Street Chelsea
    SW3 5DW London
    Geschäftsführer
    7 Red Anchor Close
    Old Church Street Chelsea
    SW3 5DW London
    EnglandBritish44192700001
    RASORES, Manny
    3 Villiers Grove
    SM2 7NN Cheam
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 Villiers Grove
    SM2 7NN Cheam
    Surrey
    Spanish106219810001
    RICHARDSON, Stewart Thomas
    Granary House Long Lane
    LU5 6HG Toddington
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Granary House Long Lane
    LU5 6HG Toddington
    Bedfordshire
    British56686210003
    SCHMID, Christian
    Untere Haldenstrasse 31
    Wohlen
    FOREIGN 5610
    Switzerland
    Geschäftsführer
    Untere Haldenstrasse 31
    Wohlen
    FOREIGN 5610
    Switzerland
    Swiss102634990001
    SCOTT, Christopher George
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish94183390001
    SMALL, Brian William
    Saturday House
    Church Lane
    NN13 5QT Helmdon
    Northampshire
    Geschäftsführer
    Saturday House
    Church Lane
    NN13 5QT Helmdon
    Northampshire
    British24329080002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    27. Mai 2017Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat HALLMARK INDUSTRIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 12. Okt. 2007
    Geliefert am 26. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • International Mezzanine Investment N.V
    Transaktionen
    • 26. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Erstellt am 12. Okt. 2007
    Geliefert am 19. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The policy being p/no LO191250952 life assured christopher scott insurer scottish equitable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Key-man policies assignment
    Erstellt am 25. Aug. 1999
    Geliefert am 31. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the policies numbered L01948767801 L0199367801 L0192667801 and all monies including bonuses accrued. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Key-man policies assignment
    Erstellt am 21. Dez. 1998
    Geliefert am 22. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in and to the policies numbered L0194867801, L0194867801, L0194867801 and all moneys including bonuses accued. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 23. Sept. 1998
    Geliefert am 07. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the senior finance documents or the mezzanine finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee for the Beneficiaries(As Defined)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 1998
    Geliefert am 30. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities on the debenture date or in the future due,owing or incurred from the company and all or any of the other companies named therein to the governor and company of the bank of scotland as security trustee for the beneficiaries (as defined) and to each of the beneficiaries under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Share pledge agreement which was executed outside the united kingdom comprising property situated outside the united kingdom
    Erstellt am 11. März 1998
    Geliefert am 30. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the governor and company of the bank of scotland (the security trustee) out of or in connection with the facilities agreement dated 12TH march 1998 and to international mezzanine capital B.V. (imc) out of or in connection with the mezzanine loan agreement dated 12TH march 1998
    Kurze Angaben
    All shares in graystone gmbh (the company) and all shares the pledgor will acquire in the company from time to time and all purchase or subscription rights relating to the shares pledged in the agreement and resulting from an increase of share capital and all present and future claims for profit distribution. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandand International Mezzanine Capital Bv
    Transaktionen
    • 30. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    • 10. Okt. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Letter of charge
    Erstellt am 10. Nov. 1997
    Geliefert am 27. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from airmatic engineering (UK) limited, cableform limited, campden instruments limited, flowcool systems limited, greenspear products limited, h a birch & company limited, inter cable systems limited, parking & equipment services limited, portobello fabrications limited and thomas eaves limited to the governor and company of the bank of scotland
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time standing to the credit of any account or accounts of the company.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 10. Nov. 1997
    Geliefert am 26. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement (as defined) and the mortgage deed
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the shares and all rights moneys benefits and other property deriving or accruing therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • International Mezzanine Capital Bv
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HALLMARK INDUSTRIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Nov. 2018Beginn der Liquidation
    29. Sept. 2022Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Conrad Alan Beighton
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Praktiker
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Steve Markey
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester
    Praktiker
    Leonard Curtis House Elms Square
    Bury New Road
    M45 7TA Whitefield
    Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0