HALLMARK INDUSTRIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HALLMARK INDUSTRIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03385127 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road M45 7TA Whitefield |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BROOMCO (1300) LIMITED | 11. Juni 1997 | 11. Juni 1997 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 20 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Nov. 2021 | 20 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Nov. 2020 | 19 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Nov. 2019 | 15 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Orion House 5 Upper St. Martin's Lane London WC2H 9EA England zum Leonard Curtis House Elms Square Bury New Road Whitefield M45 7TA am 06. Dez. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2018 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Parag Himatlal Gandesha als Geschäftsführer am 06. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Mml Capital Partners Llp Grand Buildings 1-3 Strand London WC2N 5HR zum Orion House 5 Upper St. Martin's Lane London WC2H 9EA am 12. Jan. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2014 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Parag Himatlal Gandesha als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Highland House 165 the Broadway Wimbledon London SW19 1NE England* am 04. Feb. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKS, Roderick Hilary | Geschäftsführer | c/o Mml Capital Partners Llp 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings England | United Kingdom | British | 64784320003 | |||||
| JOHAL, Balbinder Singh | Geschäftsführer | c/o Mml Capital Partners Llp 1-3 Strand WC2N 5HR London Grand Buildings England | United Kingdom | British | 124684440001 | |||||
| WALLIS, Ian Scott | Geschäftsführer | Grand Buildings Strand WC2N 5HR London 1-3 United Kingdom | England | British | 129726790001 | |||||
| FOX, Andrew Joseph | Sekretär | 165 The Broadway Wimbledon SW19 1NE London Highland House England | British | 73079390002 | ||||||
| GIBSON, John | Sekretär | Shaws Farm NE48 2JU Bellingham Northumberland | British | 19815410001 | ||||||
| PENMAN, Angus Warwick | Sekretär | 7 Red Anchor Close Old Church Street Chelsea SW3 5DW London | British | 44192700001 | ||||||
| SCOTT, Christopher George | Sekretär | 120 Lady Byron Lane Knowle B93 9BA Solihull West Midlands | British | 94183390001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||
| BOLAND, Robert Jerome | Geschäftsführer | 15 Manchester Road SK10 2EH Macclesfield Cheshire | England | British | 70534810001 | |||||
| DAVIDSON, George Alexander | Geschäftsführer | The Waterfront 300 Thames Valley Park Drive RG6 1PT Reading Berkshire | United Kingdom | British | 60518410002 | |||||
| DAVIES, Colin Ernest | Geschäftsführer | The Granary Escrick Road YO19 6BQ York North Yorkshire | United Kingdom | British | 78759470002 | |||||
| FOX, Andrew Joseph | Geschäftsführer | 165 The Broadway Wimbledon SW19 1NE London Highland House England | England | British | 73079390002 | |||||
| GANDESHA, Parag Himatlal | Geschäftsführer | 5 Upper St. Martin's Lane WC2H 9EA London Orion House England | United Kingdom | British | 142573260001 | |||||
| GIBSON, John | Geschäftsführer | Shaws Farm NE48 2JU Bellingham Northumberland | British | 19815410001 | ||||||
| GORDON CLARK, Matthew John | Geschäftsführer | 104 Cloudesley Road N1 0EB London | United Kingdom | British | 101313810001 | |||||
| KENT, Brian Hamilton | Geschäftsführer | 165 The Broadway Wimbledon SW19 1NE London Highland House England | United Kingdom | British | 15133080001 | |||||
| PENMAN, Angus Warwick | Geschäftsführer | 7 Red Anchor Close Old Church Street Chelsea SW3 5DW London | England | British | 44192700001 | |||||
| RASORES, Manny | Geschäftsführer | 3 Villiers Grove SM2 7NN Cheam Surrey | Spanish | 106219810001 | ||||||
| RICHARDSON, Stewart Thomas | Geschäftsführer | Granary House Long Lane LU5 6HG Toddington Bedfordshire | British | 56686210003 | ||||||
| SCHMID, Christian | Geschäftsführer | Untere Haldenstrasse 31 Wohlen FOREIGN 5610 Switzerland | Swiss | 102634990001 | ||||||
| SCOTT, Christopher George | Geschäftsführer | 120 Lady Byron Lane Knowle B93 9BA Solihull West Midlands | England | British | 94183390001 | |||||
| SMALL, Brian William | Geschäftsführer | Saturday House Church Lane NN13 5QT Helmdon Northampshire | British | 24329080002 | ||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003800001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für HALLMARK INDUSTRIES LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 27. Mai 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat HALLMARK INDUSTRIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 12. Okt. 2007 Geliefert am 26. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment of keyman life policy | Erstellt am 12. Okt. 2007 Geliefert am 19. Okt. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the senior finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy being p/no LO191250952 life assured christopher scott insurer scottish equitable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Key-man policies assignment | Erstellt am 25. Aug. 1999 Geliefert am 31. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the policies numbered L01948767801 L0199367801 L0192667801 and all monies including bonuses accrued. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Key-man policies assignment | Erstellt am 21. Dez. 1998 Geliefert am 22. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben All its right title and interest in and to the policies numbered L0194867801, L0194867801, L0194867801 and all moneys including bonuses accued. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental charge | Erstellt am 23. Sept. 1998 Geliefert am 07. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the senior finance documents or the mezzanine finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. März 1998 Geliefert am 30. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities on the debenture date or in the future due,owing or incurred from the company and all or any of the other companies named therein to the governor and company of the bank of scotland as security trustee for the beneficiaries (as defined) and to each of the beneficiaries under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge agreement which was executed outside the united kingdom comprising property situated outside the united kingdom | Erstellt am 11. März 1998 Geliefert am 30. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the governor and company of the bank of scotland (the security trustee) out of or in connection with the facilities agreement dated 12TH march 1998 and to international mezzanine capital B.V. (imc) out of or in connection with the mezzanine loan agreement dated 12TH march 1998 | |
Kurze Angaben All shares in graystone gmbh (the company) and all shares the pledgor will acquire in the company from time to time and all purchase or subscription rights relating to the shares pledged in the agreement and resulting from an increase of share capital and all present and future claims for profit distribution. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 10. Nov. 1997 Geliefert am 27. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from airmatic engineering (UK) limited, cableform limited, campden instruments limited, flowcool systems limited, greenspear products limited, h a birch & company limited, inter cable systems limited, parking & equipment services limited, portobello fabrications limited and thomas eaves limited to the governor and company of the bank of scotland | |
Kurze Angaben All monies now or at any time standing to the credit of any account or accounts of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 10. Nov. 1997 Geliefert am 26. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement (as defined) and the mortgage deed | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to the shares and all rights moneys benefits and other property deriving or accruing therefrom. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HALLMARK INDUSTRIES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0