COFTON LAND & PROPERTY (PROJECTS) LTD

COFTON LAND & PROPERTY (PROJECTS) LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCOFTON LAND & PROPERTY (PROJECTS) LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03386018
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von COFTON LAND & PROPERTY (PROJECTS) LTD?

    • (7011) /

    Wo befindet sich COFTON LAND & PROPERTY (PROJECTS) LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O DELOITTE LLP
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von COFTON LAND & PROPERTY (PROJECTS) LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COFTON LAND & PROPERTY (BOURNEMOUTH) LIMITED26. Juni 199726. Juni 1997
    APEXBASE LIMITED12. Juni 199712. Juni 1997

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COFTON LAND & PROPERTY (PROJECTS) LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für COFTON LAND & PROPERTY (PROJECTS) LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    23 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    32 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Jan. 2017

    30 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Ernennung eines Verwalters

    Seiten2.12B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    6 Seiten2.39B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Juli 2016

    29 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Jan. 2016

    29 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Juli 2015

    36 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Jan. 2015

    41 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Juli 2014

    41 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Jan. 2014

    24 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Juli 2013

    24 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Jan. 2013

    24 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Juli 2012

    26 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Jan. 2012

    23 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. Sept. 2011

    20 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. März 2011

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. Sept. 2010

    21 Seiten2.24B

    Wer sind die Geschäftsführer von COFTON LAND & PROPERTY (PROJECTS) LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STANTON, Andrew John
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    Sekretär
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    British85663460002
    BARNSDALL, Thomas Edward
    Marslands Farm Church Lane
    Corley
    CV7 8AS Coventry
    Geschäftsführer
    Marslands Farm Church Lane
    Corley
    CV7 8AS Coventry
    United KingdomBritish58085470001
    INNES, Clive Alexander
    Keepers Cottage
    Lower Binton
    CV37 9TE Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Keepers Cottage
    Lower Binton
    CV37 9TE Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British11962870001
    STANTON, Andrew John
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Seymour House
    Dunstall Road
    DE13 8AX Barton Under Needwood
    Staffordshire
    United KingdomBritish85663460002
    TURNER, Stephen Roger
    5 Walsall Road
    B74 4ND Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    5 Walsall Road
    B74 4ND Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish65282970001
    POSTLETHWAITE, Philip
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British20147100001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    KING, Maurice John
    Warwick House
    5 Philips Croft Hazelwood Road
    DE56 4EF Duffield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Warwick House
    5 Philips Croft Hazelwood Road
    DE56 4EF Duffield
    Derbyshire
    United KingdomBritish34418670001
    NELSON, Peter
    14 Tudor Hill
    B73 6BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    14 Tudor Hill
    B73 6BH Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish101543330002
    POSTLETHWAITE, Philip
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    64 Bennett Road
    Four Oaks
    B74 4TG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British20147100001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Hat COFTON LAND & PROPERTY (PROJECTS) LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2007
    Geliefert am 27. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 03. Nov. 2005
    Geliefert am 18. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The debt being £1,500,000.00. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 03. Nov. 2005
    Geliefert am 18. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The debt being £1,380,000.00. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of a debt
    Erstellt am 12. Jan. 2005
    Geliefert am 19. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    £2,000,000.00.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of a debt
    Erstellt am 12. Jan. 2005
    Geliefert am 19. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    £2,000,000.00.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 14. Feb. 2001
    Geliefert am 24. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Its whole right title and interest in and to the debt (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 14. Feb. 2001
    Geliefert am 24. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Its whole right title and interest in and to the debt (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 14. Feb. 2001
    Geliefert am 24. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Its whole right title and interest in and to the debt (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 14. Feb. 2001
    Geliefert am 24. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Its whole right title and interest in and to the debt (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Feb. 2001
    Geliefert am 24. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land to the north of victoria road prestatyn. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Feb. 2001
    Geliefert am 06. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £108,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    222 victoria road prestatyn t/no;-WA428581.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Erstellt am 29. Apr. 1998
    Geliefert am 08. Mai 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. März 1998
    Geliefert am 18. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific fixed charge over a book debt owed to the company by bellway homes limited to secure the liabilities of the company to the chargee being £3,150,000.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of mortgage
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 16. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £700,000 plus £300,000 commitment fees due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Agreement for sale of land at charminster dorset known as herrison hospital with all rights benefits book and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dreamhall Properties Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Dez. 1997
    Geliefert am 23. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • John Grahame Whatley
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of contracts by way of security
    Erstellt am 11. Dez. 1997
    Geliefert am 23. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "assigned documents" (as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    All rights titles benefits and interest of the company present and future under the assigned documents inclusive of the "bank bonds" and the "bellway contract" and the "dreamhall contract" all as defined as the "assigned assets". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • John Grahame Whateley
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Apr. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat COFTON LAND & PROPERTY (PROJECTS) LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    02. März 2009Beginn der Verwaltung
    25. Jan. 2018Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Charles Reid
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    Praktiker
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    Dominic Lee Zoong Wong
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Praktiker
    Deloitte Llp
    Four Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Michael John Magnay
    Po Box 810
    London
    Praktiker
    Po Box 810
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0